ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED

ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05474297
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Castlegate House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72
    A4LISU1E

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Okt. 2014

    10 Seiten4.68
    A3N3KV8Y

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Tyburn Lane Private Equity 43-44 Albemarle Street London W1S 4JJ* am 25. Okt. 2013

    2 SeitenAD01
    A2JKQXE0

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A2JKQXCW

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20
    A2JKQXEW

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    12 SeitenAA
    A2BIHRJN

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juni 2013

    Kapitalaufstellung am 11. Juni 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01
    X2ABOLDN

    Beendigung der Bestellung von Philippa Scobie als Sekretär

    1 SeitenTM02
    X232FJG1

    Ernennung von Mr Robert Savill als Sekretär

    1 SeitenAP03
    X232FJ3N

    Beendigung der Bestellung von Thomas Walsh als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01
    X21ZHKPV

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    12 SeitenAA
    A1BV4DHL

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    X1B5ZIGH

    Ernennung von Mrs Philippa Scobie als Sekretär

    1 SeitenAP03
    X12N1EB4

    Beendigung der Bestellung von David Morgan als Sekretär

    1 SeitenTM02
    X12N1DGO

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    12 SeitenAA
    L6DR7VEB

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XWYJZV04

    Änderung der Details des Direktors für Patrick O'hara am 15. Juni 2011

    2 SeitenCH01
    XWYJXV02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Gordon Parker am 15. Juni 2011

    2 SeitenCH01
    XWYJYV03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    12 SeitenAA
    LMLZBL9W

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XY1BFL8F

    Ernennung von Mr David Richard Morgan als Sekretär

    1 SeitenAP03
    XG1ZDFSX

    Änderung der Details des Direktors für John Daly am 14. Dez. 2009

    2 SeitenCH01
    XG20LFS7

    Beendigung der Bestellung von Philippa Dunkley als Sekretär

    1 SeitenTM02
    XG1YRFSA

    Wer sind die Geschäftsführer von ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SAVILL, Robert
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    Sekretär
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    176198770001
    DALY, John Francis
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBanker78960760003
    JOHNSON, Andrew William
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector68089410003
    O'HARA, Patrick
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    EnglandIrishDirector82724260003
    PARKER, Gordon
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate
    Hertfordshire
    EnglandIrishBanker85330570006
    DUNKLEY, Philippa
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Other124641320003
    MORGAN, David Richard
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Sekretär
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    147647580001
    PARKER, Gordon
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Sekretär
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    IrishBanker85330570001
    SCOBIE, Philippa
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Sekretär
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    167237380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    MURRAY, David
    Kinsale
    90 Lower Ham Road
    KT2 5BB Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Kinsale
    90 Lower Ham Road
    KT2 5BB Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandIrishDirector100446830001
    ROWAN, John
    35 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PE London
    Geschäftsführer
    35 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PE London
    IrishDirector104947440001
    WALSH, Thomas Paschal
    The Downs
    Wimbledon
    SW20 8HN London
    2a
    Geschäftsführer
    The Downs
    Wimbledon
    SW20 8HN London
    2a
    United KingdomIrishBanker130192900001

    Hat ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 14. Aug. 2007
    Geliefert am 23. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (and/or to the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge its interest in the building contract and the professional contracts including in each case all capital monies or other sums. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Aug. 2007
    Geliefert am 23. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting as general partner on behalf of the anglo chancerygate industrial partnership to the chargee (and/or to the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge its interest in the building contract and the professional contracts including in each case all capital monies or other sums. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to the hedging counterparty on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 1 mercury park cobalt avenue trafford park manchester t/no GM542830 its interest in the building contract,the professional contracts,the sale agreement,the occupational leases,the licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to the hedging counterparty on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 1 mercury park cobalt avenue trafford park manchester t/no GM542830 its interest in the building contract,the professional contracts,the sale agreement,the occupational leases,the licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 11. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (and/or to the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Part of f/h land k/s land and buildings on the north side of whitby avenue and the west side of abbey road park royal london t/no NGL173894. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 11. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company as general partner on behalf of the anglo irish chancerygate industrial partnership to the chargee ( and/or to the hedging counterpart) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Part of f/h land k/s land and buildings on the north side of whitby avenue and the west side of abbey road park royal london t/no NGL173894. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 11. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting as general partner on behalf of the anglo irish chancerygate industrial partnership to the chargee (and/or to the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property tewin court tewin road welwyn garden city t/no HD131361 and l/h property k/a 1-21 and fellowship house (also k/a land and buildings on the east side of tewin road) tewin court tewin road welwyn garden city t/no HD126454 and hd 133988. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 11. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lender (and/or to the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property tewin court tewin road welwyn garden city t/no HD131361 and l/h property k/a 1-21 and fellowship house (also k/a land and buildings on the east side of tewin road) tewin court tewin road welwyn garden city t/no HD126454 and hd 133988. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 03. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company as general partner of the anglo chancery gate industrial partnership to the chargee and/or the hedging counteparty
    Kurze Angaben
    F/H land k/a mercury park barton dock road trafford park manchester t/n GM550007, GM550008, GM539211, GM539212 intetrest in the building contract all guarantees warranties all plant materials the rents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Aug. 2005
    Geliefert am 03. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the anglo chancerygate industrial partnership to the chargee and/or to the hedging counterparty on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)

    Hat ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.13) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Okt. 2013Beginn der Liquidation
    10. März 2016Soll aufgelöst werden am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard William James Long
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford
    Praktiker
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0