BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBARRACUDA PROPCO 2 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05475205
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED?

    • Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    3440TH SINGLE MEMBER SHELF TRADING COMPANY LIMITED08. Juni 200508. Juni 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Juni 2016

    21 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 400 Capability Green Luton Bedfordshire LU1 3AE zum 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD am 22. Juni 2016

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von David Keith Langer als Geschäftsführer am 17. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    19 SeitenAA

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 08. Juni 2015

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 11. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    20 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 12. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    23 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Okt. 2011

    22 SeitenAA

    Ernennung von Tmf Corporate Administration Services Limited als Sekretär

    2 SeitenAP04

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 10 Norwich Street London EC4A 1BD United Kingdom* am 25. Okt. 2012

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Lunar House Fieldhouse Lane Globe Park Marlow Bucks SL7 1LW* am 10. Okt. 2012

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Christian Keen als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr David Langer als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    England
    Sekretär
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer06902863
    140723560001
    KEEN, Christian
    Lunar House
    Fieldhouse Lane Globe Park
    SL7 1LW Marlow
    Bucks
    Sekretär
    Lunar House
    Fieldhouse Lane Globe Park
    SL7 1LW Marlow
    Bucks
    169284670001
    MORGAN, Nicholas Mark
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    British106335450001
    VARDIGANS, Simon Geoffrey
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    Sekretär
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    British44988510001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Sekretär
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024810001
    BISS, Teresa Jane
    Inglenook
    Vicarage Lane Laleham
    TW18 1UE Staines
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Inglenook
    Vicarage Lane Laleham
    TW18 1UE Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish106335460001
    JONES, Graham Colin
    Clive Lodge
    Wellington Square
    GL50 4JU Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Clive Lodge
    Wellington Square
    GL50 4JU Cheltenham
    Gloucestershire
    British95950700001
    LANGER, David Keith
    Eton Avenue
    NW3 3ET London
    61
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Eton Avenue
    NW3 3ET London
    61
    United Kingdom
    EnglandCanadian134088480001
    MCQUATER, Mark Robert
    Lashbrook Lodge
    New Road Shiplake
    RG9 3LH Henley
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Lashbrook Lodge
    New Road Shiplake
    RG9 3LH Henley
    Oxfordshire
    United KingdomBritish72099650001
    MORGAN, Nicholas Mark
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish106335450001
    PRICE, Stephen Vincent
    Southview
    1 Earnshaw Barns Middlewich Road
    CW10 9NE Byley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Southview
    1 Earnshaw Barns Middlewich Road
    CW10 9NE Byley
    Cheshire
    EnglandBritish103543030001
    STRINGER, Richard Peter
    Agraria Road
    GU2 4LG Guildford
    68
    Surrey
    Geschäftsführer
    Agraria Road
    GU2 4LG Guildford
    68
    Surrey
    EnglandBritish150670420001
    VARDIGANS, Simon Geoffrey
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    EnglandBritish44988510001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024790001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024800001

    Hat BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 21. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a sandeman bulding 16 kinnoull street perth t/no. PTH7123 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 21. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a 60, 62 and 64 high street kirkcaldy t/no.FFE42379 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 21. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a cambio 1 corn exchange road 61 king street stirling, t/no.STG29157 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 15. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee or any delegate of the security trustee or the finance parties (or any of them) (other than newco) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 15. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2009
    • 06. März 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 12. Juni 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property being 146-148 high street, bangor, gwynedd t/no's WA734784, WA508890, WA964349 and CYM251864, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property being 22 market place, long eaton, nottinghamshire t/no DY271339, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property being 16 high street, yeadon, west yorkshire t/no's WYK102346 (f/h) and wyk 102348 (l/h), and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property being 30-32 old church road, chingford t/no EGL92917, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property being old mail house, 3 south street, ilkeston, derbyshire t/no DY368142, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 24 january 2006 and
    Erstellt am 14. Dez. 2005
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    60-64 high street kirkcaldy t/n FFE4237.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 2005
    Geliefert am 23. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and to the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a 101 front street, whickham, newcastle t/no (f/h) TY352756 and the f/h property k/a 2-6 percy street, hanley, stoke on trent t/no SF381077 and the l/h property k/a 13 london road, sheffield t/no SYK158081 for further property charged please refer to the form 395 all buildings and fixtures (including trade fixtures and fittings) and fixed plant /or machinery, all proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Erstellt am 29. Juli 2005
    Geliefert am 01. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as sandeman building 16 kinnoull street perth t/n PTH7123.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Erstellt am 29. Juli 2005
    Geliefert am 01. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as cambio 1 corn exchange road/61 king street stirling t/n STG29157.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Erstellt am 29. Juli 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee the senior finance parties (or any of them) the mezzanine finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a sandeman building 16 kinnoull street perth t/NPTH7123. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trstee for the Secured Parties) (the Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Erstellt am 29. Juli 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee the senior finance parties (or any of them) the mezzanine finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a cambio 1 corn exchange road 61 king street stirling t/n STG29157. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trstee for the Secured Parties) (the Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juli 2005
    Geliefert am 11. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties or any of them, and the mezzanine finance parties or any of them and any delegate and the opco finance parties or any of them and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 140A church street, preston t/nos LA787576 and LA749827 and the f/h property k/a 1 market place, mansfield, t/no NT271757, the f/h property k/a 65 fore bond gate, bishop auckland, t/no DU200261 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties and Opco Finance Party(Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 12. Juni 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)

    Hat BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Juni 2015Beginn der Liquidation
    30. Nov. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Kirkhope
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Praktiker
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Chad Griffin
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Praktiker
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0