GREENDAY PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREENDAY PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05484939
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREENDAY PROPERTIES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich GREENDAY PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O A R Insolvency PO BOX 797
    51 Oakwood Avenue
    WD6 9NE Borehamwood
    Hertfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREENDAY PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREENDAY PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 SeitenLIQ14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6 Highfield Gardens London NW11 9HB zum C/O a R Insolvency PO Box 797 51 Oakwood Avenue Borehamwood Hertfordshire WD69NE am 15. Jan. 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Dez. 2017

    LRESEX

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2017 bis 30. März 2017

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 12. Juli 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 01. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von John Dansky als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    2 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von GREENDAY PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DANSKY, Zehava
    6 Highfield Avenue
    NW11 9HB London
    Sekretär
    6 Highfield Avenue
    NW11 9HB London
    British108841950001
    DANSKY, Moses Eliezer
    6 Highfield Avenue
    NW11 9HB London
    Geschäftsführer
    6 Highfield Avenue
    NW11 9HB London
    United KingdomBritish108841890001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    DANSKY, John
    28 Cambridge Terrace
    NE8 1RP Gateshead
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    28 Cambridge Terrace
    NE8 1RP Gateshead
    Tyne & Wear
    EnglandBritish28631910001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GREENDAY PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Moses Eliezer Dansky
    PO BOX 797
    51 Oakwood Avenue
    WD6 9NE Borehamwood
    C/O A R Insolvency
    Hertfordshire
    06. Apr. 2016
    PO BOX 797
    51 Oakwood Avenue
    WD6 9NE Borehamwood
    C/O A R Insolvency
    Hertfordshire
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat GREENDAY PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 28. Nov. 2008
    Geliefert am 29. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43 stepney street llanelli f/h t/no WA516530 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 06. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    195 uppingham road, leicester, t/no LT360946. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 18. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hazelwood house croft road crowborough east sussex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Aug. 2006
    Geliefert am 18. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43 stepney street llanells t/no WA516530. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Juli 2006
    Geliefert am 15. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Charge over beneficial interest 90/90A brent street, london.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juli 2006
    Geliefert am 02. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    90/90A brent street london t/no AGL76042. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juli 2006
    Geliefert am 12. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 9 church street ventnor isle of wight. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 2006
    Geliefert am 03. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    17-21 cowell street llanelli and 23 cowell street llanelli f/h t/n CYM221822 and l/h t/n CYM201613. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Mai 2006
    Geliefert am 17. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1101-1103 warwick road birmingham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 29. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 07TH april 2006 and
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 22. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shop premises k/a 491-493 duke street glasgow t/n GLA57516.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GREENDAY PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Dez. 2017Beginn der Liquidation
    01. Mai 2019Soll aufgelöst werden am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Avner Radomsky
    Po Box 797 Borehamwood
    WD6 9NE Hertfordshire
    Praktiker
    Po Box 797 Borehamwood
    WD6 9NE Hertfordshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0