TT REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TT REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05494877 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TT REALISATIONS LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen (28490) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich TT REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o ABBEY TAYLOR LIMITED Blades Enterprise Centre John Street S2 4SW Sheffield |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TT REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TEMPERED TOOLS LIMITED | 14. März 2012 | 14. März 2012 |
| THE TEMPERED SPRING COMPANY LIMITED | 20. Juli 2005 | 20. Juli 2005 |
| BROOMCO (3822) LIMITED | 29. Juni 2005 | 29. Juni 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TT REALISATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TT REALISATIONS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TT REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Jan. 2015 | 13 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 14. Jan. 2015 | 13 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed tempered tools LIMITED\certificate issued on 31/10/14 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Juli 2014 | 24 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 9 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 29 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 17 Effingham Street Sheffield South Yorkshire S4 7YP am 27. Jan. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
accounts-with-accounts-type- | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 054948770008, erstellt am 08. Okt. 2013 | 41 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Douglas Maxwell als Geschäftsführer am 02. Sept. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Antony Egley als Direktor am 15. März 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clive Fletcher als Geschäftsführer am 10. Jan. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
accounts-with-accounts-type- | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed the tempered spring company LIMITED\certificate issued on 14/03/12 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TT REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYRE, Andrew | Sekretär | Crabtree Lodge 5 Newhall Lane S36 4GG Sheffield South Yorkshire | British | 80644490004 | ||||||
| BRAND, Malcolm Arthur | Geschäftsführer | c/o Abbey Taylor Limited John Street S2 4SW Sheffield Blades Enterprise Centre | England | British | 137742430001 | |||||
| EGLEY, Antony | Geschäftsführer | c/o Abbey Taylor Limited John Street S2 4SW Sheffield Blades Enterprise Centre | England | British | 176899660001 | |||||
| EYRE, Andrew | Geschäftsführer | Crabtree Lodge 5 Newhall Lane S36 4GG Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 80644490004 | |||||
| BARKER, John Michael | Sekretär | 49 Mickley Lane Totley Rise S17 4HD Sheffield South Yorkshire | British | 107220660001 | ||||||
| INNOCENT, Kenneth Ronald | Sekretär | 2 School Street Drayton NN11 9ET Daventry Northamptonshire | British | 107220510001 | ||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||
| BARKER, John Michael | Geschäftsführer | 49 Mickley Lane Totley Rise S17 4HD Sheffield South Yorkshire | England | British | 107220660001 | |||||
| BRAND, Malcolm Arthur | Geschäftsführer | Silverdene Colletts Green WR2 4RH Powick Worcestershire | United Kingdom | British | 107220580001 | |||||
| ENGLAND, Andrew Trevor | Geschäftsführer | Kingswood Close Firbeck S81 8LJ Worksop 5 Nottinghamshire | United Kingdom | British | 11045360004 | |||||
| FLETCHER, Clive | Geschäftsführer | Effingham Street 17 S4 7YP Sheffield South Yorkshire | England | English | 157752790001 | |||||
| FLETCHER, Clive | Geschäftsführer | 15 Delamere Close S20 2QE Sheffield South Yorkshire | British | 113807830001 | ||||||
| HAWKSWORTH, Neil Alan | Geschäftsführer | 5 Church View Todwick S26 1HB South Yorkshire | British | 107923010001 | ||||||
| INNOCENT, Kenneth Ronald | Geschäftsführer | 2 School Street Drayton NN11 9ET Daventry Northamptonshire | England | British | 107220510001 | |||||
| MARTIN, Michael Lawrence | Geschäftsführer | 20 Lobelia Court South Anston S25 5HX Sheffield South Yorkshire | England | British | 107220530001 | |||||
| MAXWELL, Douglas | Geschäftsführer | Effingham Street 17 S4 7YP Sheffield South Yorkshire | England | British | 114842630001 | |||||
| WOODWARD, Brian | Geschäftsführer | 30 Green Oak Drive Wales S26 5NA Sheffield Yorkshire | England | British | 111339260001 | |||||
| DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146610002 | |||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 |
Hat TT REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 08. Okt. 2013 Geliefert am 10. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juni 2010 Geliefert am 11. Juni 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Aug. 2009 Geliefert am 28. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2009 Geliefert am 10. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 03. Dez. 2008 Geliefert am 10. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All the chattels listed being dean smith & grace cnc 2413 X90 s/no 42052 bsa cypml s/no 600706736 dean smith & grace cnc 2413 x 90 /no 24175 (for details of further chattels charged please refer to the form 395) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2008 Geliefert am 04. Dez. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 18. Jan. 2006 Geliefert am 19. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 2005 Geliefert am 25. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TT REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0