GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05513232 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 05. Apr. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Richard Allen als Geschäftsführer am 30. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Allen am 06. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Samuel Wilton Lee am 01. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 30 Seiten | MA | ||||||||||
Satzungsänderung durch Gesetzgebung | 2 Seiten | CC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Povall als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Wilks als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Nicholson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Bunbury als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Euan Anstruther Gough Calthorpe als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Martin Brennan Woolhouse als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Lee als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Samuel Wilton Lee als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOLHOUSE, Martin Brennan | Sekretär | Howards Meadow Kings Cliffe PE8 6YJ Peterborough 7 Northamptonshire England | 146450850001 | |||||||
LEE, Mark Samuel Wilton | Geschäftsführer | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | Chief Financial Officer | 54866930002 | ||||
LEE, Mark Samuel Wilton | Sekretär | Chadwick End Farm Oldwich Lane West Chadwick End B93 0BH Solihull West Midlands | British | Company Director | 54866930001 | |||||
READMAN, Alison Mary | Sekretär | 12 Prince Rupert's Way WS13 7ER Lichfield | British | 69382380002 | ||||||
SMITH, Grace Mclean | Sekretär | 3 David House 43 Station Road DA15 7DD Sidcup Kent | British | 7736120003 | ||||||
ACI SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027740001 | |||||||
ALLEN, John Richard | Geschäftsführer | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | Chief Executive | 71282600003 | ||||
ANSTRUTHER -GOUGH -CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir | Geschäftsführer | Elvetham Farm House Home Farm Road RG27 8AN Hook Hampshire | Uk | British | Businessman | 194595910001 | ||||
BUNBURY, Michael William, Sir | Geschäftsführer | Flat 3 19 Redcliffe Square SW10 9LA London | England | British | Director | 70449390001 | ||||
MAHONEY, Patrick Edward | Geschäftsführer | 131 Cornwall Road HA4 6AH Ruislip Manor Middlesex | British | Director | 1622710004 | |||||
NICHOLSON, Charles Christian, Sir | Geschäftsführer | Turners Green Farm Elvetham RG27 8BE Hook Hampshire | England | British | Consultant | 43226700001 | ||||
PICK, Graham John | Geschäftsführer | Hellier Drive Wombourne WV5 8AH Wolverhampton 3 Staffordshire | England | British | Finance Director | 139309010001 | ||||
POVALL, David Edward | Geschäftsführer | St. Peters Road Harborne B17 0AU Birmingham 45 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Commercial Director | 111052510002 | ||||
WILKS, William Henry George | Geschäftsführer | 22 Cranmer Court Sloane Avenue SW3 3HN London | United Kingdom | British | Consultant | 109579700001 | ||||
ACI DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027730001 |
Hat GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Erstellt am 23. Jan. 2009 Geliefert am 28. Jan. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H property k/a harborne court 67-69 harborne road edgbaston birmingham t/no. WM172642 and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and | Erstellt am 17. Sept. 2007 Geliefert am 02. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 04. Apr. 2006 Geliefert am 20. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property k/a harborne court 67/69 harborne road edgbaston birmingham t/n WM172642. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and | Erstellt am 06. Jan. 2006 Geliefert am 12. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002 | Erstellt am 29. Nov. 2005 Geliefert am 13. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0