GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED

GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05513232
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis05. Apr. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von John Richard Allen als Geschäftsführer am 30. Sept. 2012

    1 SeitenTM01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Juni 2012

    Kapitalaufstellung am 06. Juni 2012

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2011

    16 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Allen am 06. Juni 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Samuel Wilton Lee am 01. Juni 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    30 SeitenMA

    Satzungsänderung durch Gesetzgebung

    2 SeitenCC05

    Beendigung der Bestellung von David Povall als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von William Wilks als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charles Nicholson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Bunbury als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Euan Anstruther Gough Calthorpe als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Martin Brennan Woolhouse als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Lee als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Mark Samuel Wilton Lee als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2009

    14 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOOLHOUSE, Martin Brennan
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    England
    Sekretär
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    England
    146450850001
    LEE, Mark Samuel Wilton
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishChief Financial Officer54866930002
    LEE, Mark Samuel Wilton
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director54866930001
    READMAN, Alison Mary
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    Sekretär
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    British69382380002
    SMITH, Grace Mclean
    3 David House
    43 Station Road
    DA15 7DD Sidcup
    Kent
    Sekretär
    3 David House
    43 Station Road
    DA15 7DD Sidcup
    Kent
    British7736120003
    ACI SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027740001
    ALLEN, John Richard
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive71282600003
    ANSTRUTHER -GOUGH -CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir
    Elvetham Farm House
    Home Farm Road
    RG27 8AN Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Elvetham Farm House
    Home Farm Road
    RG27 8AN Hook
    Hampshire
    UkBritishBusinessman194595910001
    BUNBURY, Michael William, Sir
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    EnglandBritishDirector70449390001
    MAHONEY, Patrick Edward
    131 Cornwall Road
    HA4 6AH Ruislip Manor
    Middlesex
    Geschäftsführer
    131 Cornwall Road
    HA4 6AH Ruislip Manor
    Middlesex
    BritishDirector1622710004
    NICHOLSON, Charles Christian, Sir
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    EnglandBritishConsultant43226700001
    PICK, Graham John
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    EnglandBritishFinance Director139309010001
    POVALL, David Edward
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishCommercial Director111052510002
    WILKS, William Henry George
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    Geschäftsführer
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    United KingdomBritishConsultant109579700001
    ACI DIRECTORS LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027730001

    Hat GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Jan. 2009
    Geliefert am 28. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H property k/a harborne court 67-69 harborne road edgbaston birmingham t/no. WM172642 and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and
    Erstellt am 17. Sept. 2007
    Geliefert am 02. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 20. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a harborne court 67/69 harborne road edgbaston birmingham t/n WM172642. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and
    Erstellt am 06. Jan. 2006
    Geliefert am 12. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 13. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0