GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC

GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 05544576
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC?

    • (9600) /

    Wo befindet sich GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5th Floor Grove House
    248a Marylebone Road
    NW16BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GOODFELLOWS GROUP PLC24. Aug. 200524. Aug. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom One Great Cumberland Place Marble Arch London W1H 7LW zum 5th Floor Grove House 248a Marylebone Road London NW16BB am 26. Apr. 2016

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Juli 2015

    17 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Secretary of State's Certificate of release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:s/s cert release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Po Box 60317 10 Orange Street Haymarket London WC2H 7WR zum One Great Cumberland Place Marble Arch London W1H 7LW am 14. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Juli 2014

    27 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Juli 2013

    23 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2013

    22 Seiten4.68

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2012

    20 Seiten4.68

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor Old Inn House Carshalton Road Sutton Surrey SM1 4RA* am 10. März 2011

    1 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    8 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    General activities 01/12/2010
    RES13

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed goodfellows group PLC\certificate issued on 30/12/10
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name30. Dez. 2010

    Beschluss zur Änderung der Firma am 01. Dez. 2010

    RES15

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Wer sind die Geschäftsführer von GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILLIAMS, Christopher John
    Quarry Park Road
    SM1 2DR Sutton
    80
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Quarry Park Road
    SM1 2DR Sutton
    80
    Surrey
    United Kingdom
    152179360001
    GOODFELLOW, Stephen Henry
    Little Orchard
    Cuddington Way
    SM2 7JA Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Orchard
    Cuddington Way
    SM2 7JA Sutton
    Surrey
    United KingdomBritish27049500002
    WALLIS, Christopher John
    Solan Ella 1-2
    Caraterra San Christofol
    Anyos
    Andorra
    Geschäftsführer
    Solan Ella 1-2
    Caraterra San Christofol
    Anyos
    Andorra
    United KingdomBritish126624250001
    WILLIAMS, Christopher John
    80 Quarry Park Road
    SM1 2DR Cheam
    Surrey
    Geschäftsführer
    80 Quarry Park Road
    SM1 2DR Cheam
    Surrey
    United KingdomBritish103272100001
    DALE, Stephen Paul
    Manor Road
    SM6 0AA Wallington
    5
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Manor Road
    SM6 0AA Wallington
    5
    Surrey
    United Kingdom
    147476700001
    GOODFELLOW, Stephen Henry
    Little Orchard
    Cuddington Way
    SM2 7JA Sutton
    Surrey
    Sekretär
    Little Orchard
    Cuddington Way
    SM2 7JA Sutton
    Surrey
    British27049500002
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    DALE, Stephen Paul
    8 Manor Road
    SM6 0AA Wallington
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Manor Road
    SM6 0AA Wallington
    Surrey
    British112194350001
    HUMPHREYS, Martin John
    3 Delius Gardens
    RH13 6RY Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    3 Delius Gardens
    RH13 6RY Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish70318090001
    KEATING, Bernadette
    Burford Road
    KT4 7SU Worcester Park
    32
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Burford Road
    KT4 7SU Worcester Park
    32
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish108015960002
    LINES, Christopher Marcus Maxwell
    Chestnut Cottage
    Sutton Park Sutton Green
    GU4 7QW Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Chestnut Cottage
    Sutton Park Sutton Green
    GU4 7QW Guildford
    Surrey
    EnglandBritish65941280004
    MORGAN, George Davd
    Mellow Close
    SM7 3QR Banstead
    2
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mellow Close
    SM7 3QR Banstead
    2
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish70038640002
    DOUGLAS NOMINEES LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    900007880001
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001

    Hat GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2006
    Geliefert am 06. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £769,972.99 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property of the company together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery thereon and therein. The mortgaged chattels. The goodwill and uncalled capital of the company. All copyrights, patents and trademarks etc. the book debts and other debts due or owing to the company both present and future. The work in progress, pre-payments investments and cash of the company both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Stephen Henry Goodfellow
    Transaktionen
    • 06. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2006
    Geliefert am 06. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £109,996.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property of the company together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery thereon and therein. The mortgaged chattels. The goodwill and uncalled capital of the company. All copyrights, patents and trademarks etc. the book debts and other debts due or owing to the company both present and future. The work in progress, pre-payments investments and cash of the company both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Martin John Humphreys
    Transaktionen
    • 06. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2006
    Geliefert am 06. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,199,972.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property of the company together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery thereon and therein. The mortgaged chattels. The goodwill and uncalled capital of the company. All copyrights, patents and trademarks etc. the book debts and other debts due or owing to the company both present and future. The work in progress, pre-payments investments and cash of the company both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr George David Morgan
    Transaktionen
    • 06. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2006
    Geliefert am 06. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £549,980.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property of the company together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery thereon and therein. The mortgaged chattels. The goodwill and uncalled capital of the company. All copyrights, patents and trademarks etc. the book debts and other debts due or owing to the company both present and future. The work in progress, pre-payments investments and cash of the company both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Christopher Marcus Maxwell
    Transaktionen
    • 06. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 10. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GG PROFESSIONAL SERVICES GROUP PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. März 2011Beginn der Liquidation
    07. Jan. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Blandford Ryman
    Shipleys Llp
    10 Orange Street
    WC2H 7DQ Haymarket
    London
    Praktiker
    Shipleys Llp
    10 Orange Street
    WC2H 7DQ Haymarket
    London
    Conrad Alan Beighton
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praktiker
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Anthony Davidson
    10 Orange Street
    Haymarket
    WC2H 7DQ London
    Praktiker
    10 Orange Street
    Haymarket
    WC2H 7DQ London
    Andrew John Duncan
    Leonard Curtis One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Praktiker
    Leonard Curtis One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Neil A Bennett
    Leonard Curtis
    One Great Cumberland Place
    W1H 7LW Marble Arch
    London
    Praktiker
    Leonard Curtis
    One Great Cumberland Place
    W1H 7LW Marble Arch
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0