SML (SR) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSML (SR) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05546675
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SML (SR) LIMITED?

    • Produktion von Fernsehprogrammen (59113) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich SML (SR) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 1 First Floor Brook Business Centre
    Cowley Mill Road
    UB8 2FX Uxbridge
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SML (SR) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SPLASH MEDIA LIMITED25. Aug. 200525. Aug. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SML (SR) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für SML (SR) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    27 SeitenLIQ14

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2021

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2020

    27 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2019

    27 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2018

    19 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom St Martin's House the Runway South Ruislip Middlesex HA4 6SE zum Unit 1 First Floor Brook Business Centre Cowley Mill Road Uxbridge UB8 2FX am 10. Jan. 2018

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2017

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2016

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2015

    17 Seiten4.68

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed splash media LIMITED\certificate issued on 12/01/15
    3 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 18. Dez. 2014

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU zum St Martin's House the Runway South Ruislip Middlesex HA4 6SE am 09. Jan. 2015

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Okt. 2014

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Okt. 2014

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Apr. 2014

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    27 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Iffigenia Vardanis als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Sept. 2012

    Kapitalaufstellung am 03. Sept. 2012

    • Kapital: GBP 140,000
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von SML (SR) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NICHOLLS, Clare Helen
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    Sekretär
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    British113431010001
    CHANDOS, Thomas Orlando, Viscount
    149 Gloucester Avenue
    NW1 8LA London
    Geschäftsführer
    149 Gloucester Avenue
    NW1 8LA London
    EnglandBritish34942190003
    NICHOLLS, Clare Helen
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    Geschäftsführer
    Flat 6 Shelley Court
    56 Tite Street Chelsea
    SW3 4JB London
    EnglandBritish113431010001
    TENENBAUM, Jane Elaine
    17 Spaniards End
    NW3 7JG London
    Geschäftsführer
    17 Spaniards End
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish107872110001
    ROBERTS, Jennifer
    69 Harbord Street
    Fulham
    SW6 6PL London
    Sekretär
    69 Harbord Street
    Fulham
    SW6 6PL London
    British100796870001
    HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    73037780002
    HAMMONDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Sekretär
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580008
    GARDNER, Malcolm William
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    Geschäftsführer
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    EnglandBritish101769350001
    LEACH, David Dennis Wilkie
    39 Clavering Avenue
    Barnes
    SW13 8DX London
    Geschäftsführer
    39 Clavering Avenue
    Barnes
    SW13 8DX London
    EnglandBritish111135630001
    REES, William Arwel
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    Geschäftsführer
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritish3205450001
    SALMON, Peter
    232 St Margarets Road
    TW1 1NL Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    232 St Margarets Road
    TW1 1NL Twickenham
    Middlesex
    British106364220001
    VARDANIS, Iffigenia Lily
    Richmond Cottage
    High Street Hurley
    SL6 5LT Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Richmond Cottage
    High Street Hurley
    SL6 5LT Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish107872010001
    HAMMONDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Geschäftsführer
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    73774730003

    Hat SML (SR) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. Feb. 2012
    Geliefert am 07. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £15,975.00. see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Woburn Estate Company Limited and Bedford Estates Nominees Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. Feb. 2012
    Geliefert am 07. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £9,600 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Woburn Estate Company Limited and Bedford Estates Nominees Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge
    Erstellt am 23. Dez. 2009
    Geliefert am 05. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment and by way of fixed charge to the bank the borrowers right title and interest in and to the programme the rights in respect of the programme subject to the itv licence the sole worldwide exclusive and irrevocable right to distribute reproduce exhibit licence and otherwise exploit and deal in and with the programme all rights of copyright in the original screenplay of the programme all ancillary publishing all rights of the borrower pursuant to any agreement the itv licence and all of the borrower's rights title and benefit to and in the same including without limitation any and all sums of money whatever payable to or on account of the borrower by itv pursuant to the itv licence the distribution agreement the proceeds of any and all policies of insurance now or in the future taken out by the borrower in respect of the programme and or the rights all sums from time to time standing to the credit of the borrower in the account. Floating charge any and all of the borrower's rights whatsoever and wheresoever present and or future in and to the property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge
    Erstellt am 30. Juli 2009
    Geliefert am 07. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of assignment and by way of fixed charge to teh bank and borrowers right title and interest see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juli 2009
    Geliefert am 16. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co
    Transaktionen
    • 16. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 03. Okt. 2008
    Geliefert am 14. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all right, title and interest in and to the programme being the programme or series of television programmes called piers morgan on..... And the rights in respect of the programme, all rights of copyright, all sums from time to time standing to the credit of the borrower in the account and floating charge all rights in and to the property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over the television programme entitled 'sandbanks'
    Erstellt am 31. Aug. 2007
    Geliefert am 05. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title and interest in and to the programme. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2005
    Geliefert am 09. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Television Corporation PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SML (SR) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Okt. 2013Beginn der Verwaltung
    30. Okt. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    2
    DatumTyp
    05. Apr. 2023Soll aufgelöst werden am
    30. Okt. 2014Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Vorgeschlagener Liquidator
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Vorgeschlagener Liquidator
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0