SML (SR) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SML (SR) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05546675 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SML (SR) LIMITED?
- Produktion von Fernsehprogrammen (59113) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich SML (SR) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 1 First Floor Brook Business Centre Cowley Mill Road UB8 2FX Uxbridge |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SML (SR) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SPLASH MEDIA LIMITED | 25. Aug. 2005 | 25. Aug. 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SML (SR) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SML (SR) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 27 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2021 | 21 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2020 | 27 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2019 | 27 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2018 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St Martin's House the Runway South Ruislip Middlesex HA4 6SE zum Unit 1 First Floor Brook Business Centre Cowley Mill Road Uxbridge UB8 2FX am 10. Jan. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2017 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2016 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2015 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed splash media LIMITED\certificate issued on 12/01/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU zum St Martin's House the Runway South Ruislip Middlesex HA4 6SE am 09. Jan. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Okt. 2014 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Okt. 2014 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Apr. 2014 | 18 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 27 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iffigenia Vardanis als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SML (SR) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICHOLLS, Clare Helen | Sekretär | Flat 6 Shelley Court 56 Tite Street Chelsea SW3 4JB London | British | 113431010001 | ||||||
| CHANDOS, Thomas Orlando, Viscount | Geschäftsführer | 149 Gloucester Avenue NW1 8LA London | England | British | 34942190003 | |||||
| NICHOLLS, Clare Helen | Geschäftsführer | Flat 6 Shelley Court 56 Tite Street Chelsea SW3 4JB London | England | British | 113431010001 | |||||
| TENENBAUM, Jane Elaine | Geschäftsführer | 17 Spaniards End NW3 7JG London | United Kingdom | British | 107872110001 | |||||
| ROBERTS, Jennifer | Sekretär | 69 Harbord Street Fulham SW6 6PL London | British | 100796870001 | ||||||
| HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham West Midlands | 73037780002 | |||||||
| HAMMONDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580008 | |||||||
| GARDNER, Malcolm William | Geschäftsführer | 18 Elm Grove Road Ealing W5 3JJ London | England | British | 101769350001 | |||||
| LEACH, David Dennis Wilkie | Geschäftsführer | 39 Clavering Avenue Barnes SW13 8DX London | England | British | 111135630001 | |||||
| REES, William Arwel | Geschäftsführer | Woodlands Old Monmouth Road NP7 8BU Abergavenny Gwent | United Kingdom | British | 3205450001 | |||||
| SALMON, Peter | Geschäftsführer | 232 St Margarets Road TW1 1NL Twickenham Middlesex | British | 106364220001 | ||||||
| VARDANIS, Iffigenia Lily | Geschäftsführer | Richmond Cottage High Street Hurley SL6 5LT Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 107872010001 | |||||
| HAMMONDS DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 73774730003 |
Hat SML (SR) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 01. Feb. 2012 Geliefert am 07. Feb. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £15,975.00. see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 01. Feb. 2012 Geliefert am 07. Feb. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £9,600 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 23. Dez. 2009 Geliefert am 05. Jan. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment and by way of fixed charge to the bank the borrowers right title and interest in and to the programme the rights in respect of the programme subject to the itv licence the sole worldwide exclusive and irrevocable right to distribute reproduce exhibit licence and otherwise exploit and deal in and with the programme all rights of copyright in the original screenplay of the programme all ancillary publishing all rights of the borrower pursuant to any agreement the itv licence and all of the borrower's rights title and benefit to and in the same including without limitation any and all sums of money whatever payable to or on account of the borrower by itv pursuant to the itv licence the distribution agreement the proceeds of any and all policies of insurance now or in the future taken out by the borrower in respect of the programme and or the rights all sums from time to time standing to the credit of the borrower in the account. Floating charge any and all of the borrower's rights whatsoever and wheresoever present and or future in and to the property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 30. Juli 2009 Geliefert am 07. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of assignment and by way of fixed charge to teh bank and borrowers right title and interest see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juli 2009 Geliefert am 16. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 03. Okt. 2008 Geliefert am 14. Okt. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge all right, title and interest in and to the programme being the programme or series of television programmes called piers morgan on..... And the rights in respect of the programme, all rights of copyright, all sums from time to time standing to the credit of the borrower in the account and floating charge all rights in and to the property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over the television programme entitled 'sandbanks' | Erstellt am 31. Aug. 2007 Geliefert am 05. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The right title and interest in and to the programme. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2005 Geliefert am 09. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SML (SR) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0