PANGOLIN ENTERPRISES LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePANGOLIN ENTERPRISES LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05554990
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PANGOLIN ENTERPRISES LTD?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich PANGOLIN ENTERPRISES LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1st Floor, 27 Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PANGOLIN ENTERPRISES LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für PANGOLIN ENTERPRISES LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2021

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor, 181 Queensway Bletchley Milton Keynes MK2 2DZ England zum 1st Floor, 27 Shirwell Crescent Furzton Milton Keynes MK4 1GA am 03. Aug. 2021

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Malcolm Hall am 02. Dez. 2020

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2020

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    5 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Notification of a person with significant control statement

    2 SeitenPSC08

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Cessation of Karen Ann Hall as a person with significant control on 31. Dez. 2017

    1 SeitenPSC07

    Cessation of James Malcolm Hall as a person with significant control on 31. Dez. 2017

    1 SeitenPSC07

    Beschlüsse

    Resolutions
    6 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor 181 Queensway Bletchley Milton Keynes MK2 2DZ zum 1st Floor, 181 Queensway Bletchley Milton Keynes MK2 2DZ am 26. Sept. 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von PANGOLIN ENTERPRISES LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HALL, Karen Ann
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    Sekretär
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    British107957560001
    HALL, James Malcolm
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    Geschäftsführer
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    EnglandBritish108138210003
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PANGOLIN ENTERPRISES LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr James Malcolm Hall
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    06. Apr. 2016
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mrs Karen Ann Hall
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    06. Apr. 2016
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für PANGOLIN ENTERPRISES LTD?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    31. Dez. 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat PANGOLIN ENTERPRISES LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Mai 2008
    Geliefert am 24. Mai 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15 old groveway simpson milton keynes assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 16. Apr. 2008
    Geliefert am 22. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 18. Dez. 2007
    Geliefert am 19. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    16 colley hill bradwell milton keynes MK13 9DA. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 06. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    44 westfield road bletchley bucks. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Mai 2007
    Geliefert am 12. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £168,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    6 lamb close newport pagnell buckinghamshire.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 12. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. März 2007
    Geliefert am 29. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7 william smith close woolstone milton keynes bucks.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 2007
    Geliefert am 17. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    2 thane court stantonbury milton keyenes bucks. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Sept. 2006
    Geliefert am 26. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 164 tickford street newport pagnell. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juni 2006
    Geliefert am 27. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 warren bank simpson milton keynes buckinghamshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2006
    Geliefert am 11. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    17 thresher grove greenleys milton keynes. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2006
    Geliefert am 04. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0