CROSS HULLER UK LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCROSS HULLER UK LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05567165
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CROSS HULLER UK LTD?

    • (2924) /

    Wo befindet sich CROSS HULLER UK LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP
    St. Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CROSS HULLER UK LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INTERCEDE 2065 LIMITED19. Sept. 200519. Sept. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROSS HULLER UK LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für CROSS HULLER UK LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2011

    15 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Gerichtsbeschluss, der dem freiwilligen Liquidator die Erlaubnis zum Rücktritt erteilt

    1 Seiten4.35

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    6 SeitenLIQ MISC OC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Baker Tilly R&R Llp St. Philips Point Temple Row Birmingham West Midlands B2 5AF England am 12. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Sept. 2010

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Fourth Floor Fort Dunlop Fort Parkway Birmingham West Midlands B24 9FD am 04. Jan. 2010

    1 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    16 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    20 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von CROSS HULLER UK LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOYD, John
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    Sekretär
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    British135386290001
    BOYD, John
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    United KingdomBritish135386290001
    HAGENAU, Gerhard
    Wolfsgrube 5
    Chieming
    83339
    Germany
    Geschäftsführer
    Wolfsgrube 5
    Chieming
    83339
    Germany
    GermanyGerman139197540001
    GAUNT, Michael Ian
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    British113180730001
    GOOD, Ian Scott
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    British106898310001
    GRIFFITHS, David Anthony
    Kilverley Close
    Allerton
    L18 3NW Liverpool
    1
    Sekretär
    Kilverley Close
    Allerton
    L18 3NW Liverpool
    1
    British141151040001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    BENJAMIN, James Cover
    10213 Discovery Terrace
    Bradenton
    Florida 34212
    Usa
    Geschäftsführer
    10213 Discovery Terrace
    Bradenton
    Florida 34212
    Usa
    American104568880001
    COPE, Roger
    3730 Rock Valley Road
    Metamora
    Michigan 48455
    Usa
    Geschäftsführer
    3730 Rock Valley Road
    Metamora
    Michigan 48455
    Usa
    Usa113180750001
    GAUNT, Michael Ian
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish113180730001
    GOOD, Ian Scott
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    British106898310001
    MANTLE, Neil
    19c Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    19c Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    British124095260001
    RUDDOCK, Alan
    25 Grove Park Avenue
    West Derby
    L12 5JP Liverpool
    Geschäftsführer
    25 Grove Park Avenue
    West Derby
    L12 5JP Liverpool
    British35199050001
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900027570001

    Hat CROSS HULLER UK LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 06. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re cross huller UK LTD business premium account, account number 90274909. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Consolidated amended and restated security agreement
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security interest in and lien upon all of its right, title and interest in, to and under all personal property and other assets, whether then owned by or owing to, or thereafter acquired by or arising in favour of the grantor and whether owned or consigned by or to, or leased from or to, the grantor, and regardless of where located (the collateral). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Consolidated amended and restated patent and trademark security agreement
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A continuing first priority security interest in and lien (as applicable) upon all of its right, title and interest in, to and under all of its owned and thereafter acquired or arising and filed patnets and patent applications and all of its patent licenses. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Consolidated amended and restated copyright security agreement
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A continuing first priority security interest in and lien (as applicable) upon all of its right, title and interest in, to and under all of its then owned and thereafter acquired or arising and registered copyrights, all copyright licences to which it is a party and all license fees and royalties arising. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to the agents or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc as Agent and Trustee for Itself and the Other Lenders
    Transaktionen
    • 12. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2005
    Geliefert am 26. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party and the company to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc as Agent and Trustee for Itself and the Other Lenders (The Agent)
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 06. Okt. 2005
    Geliefert am 24. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, any credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in, to and under all personal property and other assets including all accounts, chattel paper, documents, general intangibles and all goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc (The Agent)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Patent and trademark security agreement
    Erstellt am 06. Okt. 2005
    Geliefert am 24. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party, the borrower to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in, to and under the intellectual property collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc (The Agent)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Copyright security agreement
    Erstellt am 06. Okt. 2005
    Geliefert am 24. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party, the borrower to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in, to and under the intellectual property collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc (The Agent)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Cash pledge and collateral agreement
    Erstellt am 06. Okt. 2005
    Geliefert am 24. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party, the foreign borrower, any U.S. affiliate to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in the cash collateral being the cash collateral pledged by the grantor to the agent pursuant to the cash pledge and collateral agreement in an amount equal to (euro) 45,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc (The Agent)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CROSS HULLER UK LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Sept. 2010Beginn der Liquidation
    04. Apr. 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lynn Robert Bailey
    St Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Praktiker
    St Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Guy Edward Brooke Mander
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Praktiker
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Graham Paul Bushby
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Praktiker
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0