HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05576842 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 055768420009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 055768420008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 055768420007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 055768420009, erstellt am 10. Okt. 2018 | 75 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung einer Belastung | Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 055768420008, erstellt am 01. Dez. 2015 | 85 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr James Alexander Burrell als Direktor am 10. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 055768420007 | 91 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Geraldine Josephine Gallagher als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURRELL, James Alexander | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | 192486560001 | |||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | Irish | 185108770001 | |||||
| HUNTER, Gail Susan | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | 89557480002 | |||||
| TROY, Anthony Gerard | Geschäftsführer | Fountains Bent Darley Road, Bristwith HG3 2PN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 104500230001 | |||||
| BENNISON, Matthew Edward | Sekretär | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | 161786770001 | |||||||
| DOUBLEDAY, Timothy | Sekretär | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156121100001 | ||||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Sekretär | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | 185108770001 | ||||||
| PEARCE, Emma Jane | Sekretär | 28 Eagle House 30 Eagle Wharf Road N1 7EH London | British | 107899440001 | ||||||
| SOLOMAN, Sheila Margaret | Sekretär | 5 The Green Hardingstone NN4 7BU Northampton Northamptonshire | British | 45253560008 | ||||||
| BELLONE, Norman Edward | Geschäftsführer | Gardens Cottage Bagendon GL7 7DU Cirencester Gloucestershire | British | 126414070001 | ||||||
| BENNISON, Matthew Edward | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | British | 108534390002 | |||||
| DAY, Mark | Geschäftsführer | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | 124446000001 | |||||
| DOUBLEDAY, Timothy John | Geschäftsführer | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 91011320001 | |||||
| HOLDEN, Elizabeth Jane Dilwihs | Geschäftsführer | 12 Carver Road SE24 9LT London | British | 107915150001 | ||||||
| LITTLEWOOD, Jane Alison | Geschäftsführer | 5 Shenhurst Close SK9 6NB Wilmslow Cheshire | British | 50102790004 | ||||||
| NISBETT, Paul Sandle | Geschäftsführer | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | 132613500001 | |||||
| PEARCE, Emma Jane | Geschäftsführer | 28 Eagle House 30 Eagle Wharf Road N1 7EH London | British | 107899440001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayley Conference Centres Enterprise Limited | 06. Apr. 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HAYLEY CONFERENCE CENTRES ACQUISITIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 10. Okt. 2018 Geliefert am 11. Okt. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 01. Dez. 2015 Geliefert am 03. Dez. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. Juni 2014 Geliefert am 18. Juni 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| English law deed of accession | Erstellt am 27. Feb. 2013 Geliefert am 01. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2011 Geliefert am 10. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 18. Juni 2007 Geliefert am 22. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over deposit | Erstellt am 12. Feb. 2007 Geliefert am 16. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company entire right title and interest (both present and future) in and to all money in any currency now or hereinafter standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. März 2006 Geliefert am 06. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003 and | Erstellt am 29. Sept. 2005 Geliefert am 07. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0