EPIC (WIDNES) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEPIC (WIDNES) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05603111
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EPIC (WIDNES) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Level 13, Broadgate Tower
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STADIUM (WIDNES) LIMITED15. Nov. 200515. Nov. 2005
    INHOCO 3257 LIMITED25. Okt. 200525. Okt. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Nov. 2019

    5 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. März 2019

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Daniel O'neill als Geschäftsführer am 26. März 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Okt. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2017 bis 30. Juni 2018

    1 SeitenAA01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2018 bis 30. Sept. 2018

    1 SeitenAA01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschlüsse

    Increase authorised capital from £1000 to £2000 07/12/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Ernennung von Mr Daniel O'neill als Direktor am 08. Dez. 2017

    2 SeitenAP01

    Eintragung der Belastung 056031110018, erstellt am 08. Dez. 2017

    45 SeitenMR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name11. Dez. 2017

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 06. Dez. 2017

    RES15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Welton Grange Welton Brough East Yorkshire HU15 1NB zum Level 13, Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2EW am 11. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Calum Scott Bruce als Direktor am 08. Dez. 2017

    2 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 07. Dez. 2017

    • Kapital: GBP 2,000,000
    3 SeitenSH01

    Beendigung der Bestellung von Amanda Jayne Standish als Geschäftsführer am 08. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Dyson Healey als Geschäftsführer am 08. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Edwin Dyson Healey als Geschäftsführer am 08. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alexander Martin Clare als Geschäftsführer am 08. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Stuart Fish als Geschäftsführer am 08. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Stuart Fish als Sekretär am 08. Dez. 2017

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Rankin Vallance Laing als Direktor am 08. Dez. 2017

    2 SeitenAP01

    Cessation of Stadium (Newport) Ltd as a person with significant control on 08. Dez. 2017

    1 SeitenPSC07

    Wer sind die Geschäftsführer von EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRUCE, Calum Scott
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    Geschäftsführer
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    ScotlandScottish198600380001
    LAING, Rankin Vallance
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    Geschäftsführer
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    ScotlandBritish185571350001
    CROOKS, Michael Clive
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road, Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road, Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    British48504730008
    FISH, Andrew Stuart
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Sekretär
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    172292060001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLARE, Alexander Martin
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish184073370001
    CROOKS, Michael Clive
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Grange Westfield Road
    Eppleworth Road Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish48504730009
    FISH, Andrew Stuart
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish99181180003
    HEALEY, Edwin Dyson
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish1798990001
    HEALEY, Paul Dyson
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish7349500004
    O'NEILL, Daniel
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    Geschäftsführer
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13, Broadgate Tower
    England
    United KingdomBritish211889980001
    STANDISH, Amanda Jayne
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish172278520001
    SWALES, Paul Nigel
    3 Orchard Close
    WF8 3NL Pontefract
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Orchard Close
    WF8 3NL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish42213720002
    WILLOX, Shaun
    10 Bull Pasture
    South Cave
    HU15 2HT Brough
    North Humberside
    Geschäftsführer
    10 Bull Pasture
    South Cave
    HU15 2HT Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish99708360002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EPIC (WIDNES) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 Broadgate Tower
    United Kingdom
    08. Dez. 2017
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 Broadgate Tower
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageUk Companies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer10978359
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Stadium (Newport) Ltd
    Cowgate
    Welton
    HU15 1NB Brough
    Welton Grange
    England
    06. Apr. 2016
    Cowgate
    Welton
    HU15 1NB Brough
    Welton Grange
    England
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom Company Law - Companies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Registrierungsnummer03772449
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat EPIC (WIDNES) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Dez. 2017
    Geliefert am 12. Dez. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All estates or interests in any freehold or leasehold property now owned by the company including the freehold and leasehold property known as widnes shopping park, widnes, cheshire, WA8 7NT registered at the land registry under title numbers CH223723, CH398553, CH399521, CH448374, CH574659 and CH623717.. Please see the charge instrument for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aviva Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 27. März 2015
    Geliefert am 01. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Widnes shopping park temperley street widnes title no CH398553, CH448374, CH574659, CH3995421, CH623717 and CH223723.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (Party A)
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Jan. 2015
    Geliefert am 16. Jan. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Leasehold land on the west side of green oaks way widnes title number CH623717.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 31. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Sept. 2013
    Geliefert am 02. Okt. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    L/H land at widnes shopping park green oaks way widnes whole t/no CH607150 and part t/nos CH257449 CH602602 and LA356680. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 31. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 10. Apr. 2012
    Geliefert am 19. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The real property, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 31. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge and assignment
    Erstellt am 05. März 2010
    Geliefert am 26. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest present and future to in and arising out of or in respect of the agreements being the agreement to lease in respect of units 9 and 10 widnes shopping park widnes, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 26. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge and assignment
    Erstellt am 05. März 2010
    Geliefert am 13. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest present and future to in and arising out of or in respect of the agreements being the agreement to lease in respect of unit 5 widnes shopping park widnes, made between the company and poundstretcher limited. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 13. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge and assignment
    Erstellt am 29. Okt. 2009
    Geliefert am 06. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest present and future to, in and arising out or in respect of, the agreements, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge and assignment
    Erstellt am 14. Jan. 2009
    Geliefert am 17. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest present and future to, in and arising out or in respect of the agreements. Agreements means lease made between stadium (widnes) limited, river island clothing co. Limited. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) the Security Trustee
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge of assignment
    Erstellt am 14. Juli 2008
    Geliefert am 19. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge and assignment
    Erstellt am 06. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The agreements being the agreement to lease in respect of the property k/a the windmill centre lagsdale road widnes the benefit of the agreement see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2008
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 2008
    Geliefert am 25. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unregistered land demised by a lease and deed of variation dated 14 june 2007 made between the council of the borough of halton and the mortgagor land by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 2008
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. März 2008
    Geliefert am 19. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The windmill centre lugsdale road widnes t/nos CH448374, CH398553, CH399521 and CH223723 by way of fixed charge, all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. März 2008
    Geliefert am 19. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge and assignment
    Erstellt am 13. März 2008
    Geliefert am 19. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest to in and arising out or in respect of the agreements and all rights titles and benefits monies receivable and interests of the company under them see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 26. Apr. 2006
    Geliefert am 27. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 11. Jan. 2006
    Geliefert am 13. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right,title and interst present and future to in and arising out or in respect of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 2005
    Geliefert am 03. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h land known as the windmill centre lugsdale road widnes t/n's CH448374 CH38553 CH399521 and f/h land being the former site of a pump house lying to the east of timerley street widnes t/n CH223723,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EPIC (WIDNES) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Apr. 2020Aufgelöst am
    28. März 2019Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David F Rutherford
    60 Constitution Street
    Leith
    EH6 6RR Edinburgh
    Praktiker
    60 Constitution Street
    Leith
    EH6 6RR Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0