HIRONDELLE WINES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHIRONDELLE WINES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05606416
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HIRONDELLE WINES LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich HIRONDELLE WINES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o INQUESTA CORPORATE RECOVERY & INSOLVENCY
    St Johns Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIRONDELLE WINES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für HIRONDELLE WINES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 SeitenLIQ14
    A7AVGWE0

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Beach Approach Filey North Yorkshire YO14 9LB zum C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St Johns Terrace 11-15 New Road Manchester M26 1LS am 09. Jan. 2018

    2 SeitenAD01
    A6LSSWLE

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600
    A6LSSWL5

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Dez. 2017

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR zum 1 Beach Approach Filey North Yorkshire YO14 9LB am 15. Sept. 2017

    2 SeitenAD01
    A6EAUKWR

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in Gläubigerinsolvenz

    3 SeitenREST-CVL
    R6DZZ8DL

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2014

    17 Seiten2.24B
    A3H13XPF

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 19. Sept. 2014

    1 Seiten2.35B
    A3H13XP7

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Aug. 2014

    18 Seiten2.24B
    A3FYS56O

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Feb. 2014

    21 Seiten2.24B
    A336J1ZV

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B
    A2G7QRL7

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Aug. 2013

    22 Seiten2.24B
    A2G2KL47

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B
    A22OTN0Q

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Feb. 2013

    24 Seiten2.24B
    A22M8CRC

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B
    A1GA460X

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. März 2012

    20 Seiten2.24B
    A18B040A

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18
    A10AGFVF

    Vorschlag des Verwalters

    12 Seiten2.17B
    ALG0NZDA

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B
    ALG0RZDE

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 7-10 the Beach Filey North Yorkshire YO14 9LA United Kingdom am 04. Okt. 2011

    2 SeitenAD01
    A58QLXYT

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B
    A58QKXYS

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Melton Business Park 2 Redcliff Road Melton East Riding of Yorkshire HU14 3RS am 09. Juni 2011

    1 SeitenAD01
    XUZHTUUO

    Beendigung der Bestellung von Richard Firth als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01
    XUZ0DUUR

    Wer sind die Geschäftsführer von HIRONDELLE WINES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WELSBY, Jonathan Alan
    Beach Approach
    YO14 9LB Filey
    1
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beach Approach
    YO14 9LB Filey
    1
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector65909400004
    FIRTH, Richard Sean
    2 Redcliff Road
    HU14 3RS Melton
    Melton Business Park
    East Riding Of Yorkshire
    Sekretär
    2 Redcliff Road
    HU14 3RS Melton
    Melton Business Park
    East Riding Of Yorkshire
    152446810001
    WELSBY, Ian Armstrong
    11 Newland Avenue
    YO25 6TX Driffield
    East Yorkshire
    Sekretär
    11 Newland Avenue
    YO25 6TX Driffield
    East Yorkshire
    BritishConsultant33861440002
    WELSBY, Jonathan Alan
    21 Kings Mill Road
    YO25 6TT Driffield
    East Yorkshire
    Sekretär
    21 Kings Mill Road
    YO25 6TT Driffield
    East Yorkshire
    BritishDirector65909400003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Bevollmächtigter Sekretär
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027310001
    FIRTH, Richard Sean
    18 Common Lane
    HU15 1PT Welton
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 Common Lane
    HU15 1PT Welton
    East Yorkshire
    EnglandBritishFinance Advisor75430840002
    LASLETT, Alan
    Red Lodge
    Oxspring
    S36 8YW Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red Lodge
    Oxspring
    S36 8YW Sheffield
    South Yorkshire
    BritishBroker123464160001
    WELSBY, Ian Armstrong
    11 Newland Avenue
    YO25 6TX Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Newland Avenue
    YO25 6TX Driffield
    East Yorkshire
    BritishConsultant33861440002
    WELSBY, Kerry Anne
    21 Kings Mill Road
    YO25 6TT Driffield
    North Humberside
    Geschäftsführer
    21 Kings Mill Road
    YO25 6TT Driffield
    North Humberside
    BritishDirector112875700001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027300001

    Hat HIRONDELLE WINES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 22. Apr. 2008
    Geliefert am 23. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2008
    Debenture
    Erstellt am 22. Apr. 2008
    Geliefert am 23. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 02. Juni 2006
    Geliefert am 03. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Kings chambers 1-3 kings street sheffield. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 02. Juni 2006
    Geliefert am 03. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hilary house 213 edmund road sheffield south yorkshire t/n syk 392844. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Mai 2006
    Geliefert am 11. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat HIRONDELLE WINES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Sept. 2011Beginn der Verwaltung
    19. Sept. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathon P Sumpton
    Ernst & Young
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    Leeds Ls11 5qr
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    Leeds Ls11 5qr
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    18. Dez. 2017Beginn der Liquidation
    03. Nov. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Wiseglass
    St Johns Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester
    Praktiker
    St Johns Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0