ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED

ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameARROW SEISMIC INVEST I LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05616405
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED?

    • (6110) /

    Wo befindet sich ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    11th Floor 66 Chiltern Street
    W1U 6JT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 Seiten4.71

    Beendigung der Bestellung von David Ian Humphries als Geschäftsführer am 22. Apr. 2013

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2012

    13 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2011

    11 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Rsm Tenon Recovery Sherlock House 73 Baker Street London W1U 6rd am 07. März 2011

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 the Heights Brooklands Weybridge Surrey KT13 0NY am 06. Aug. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Juni 2010

    LRESSP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Dez. 2009

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2009

    • Kapital: GBP 1
    • Kapital: USD 47,000,000
    SH01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    2 Seiten88(2)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PINTO, Maria Candida Ferreira
    The Heart
    KT12 1GE Walton-On-Thames
    423
    Surrey
    Sekretär
    The Heart
    KT12 1GE Walton-On-Thames
    423
    Surrey
    Portuguese130391900001
    HISCOX, Gaius Maxwell
    Kenwood Drive
    Hersham
    KT12 5AX Walton-On-Thames
    39
    Surrey
    Geschäftsführer
    Kenwood Drive
    Hersham
    KT12 5AX Walton-On-Thames
    39
    Surrey
    EnglandBritish130390300001
    PINTO, Maria Candida Ferreira
    The Heart
    KT12 1GE Walton-On-Thames
    423
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Heart
    KT12 1GE Walton-On-Thames
    423
    Surrey
    EnglandPortuguese130391900001
    STEEN-NILSEN, Christin
    1352 Kolsaas
    Mosebakken 14
    Norway
    Geschäftsführer
    1352 Kolsaas
    Mosebakken 14
    Norway
    NorwayNorwegian130392650001
    SUNDBY, Harald Simon
    Sandefjord
    Baatstangveien 65a
    3230
    Norway
    Geschäftsführer
    Sandefjord
    Baatstangveien 65a
    3230
    Norway
    NorwayNorwegian130386520001
    ASHTON TAYLOR, Mark
    7 Chine Farm Place
    Main Road, Knockholt
    TN14 7LG Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    7 Chine Farm Place
    Main Road, Knockholt
    TN14 7LG Sevenoaks
    Kent
    British103581840002
    CAINES, Michael Alan
    6 Farnham Close
    RH11 9RA Crawley
    West Sussex
    Sekretär
    6 Farnham Close
    RH11 9RA Crawley
    West Sussex
    British102249140002
    LEADENHALL SECRETARIES LIMITED
    1st Floor East Wing Ibex House
    42-47 Minories
    EC3N 1HA London
    Sekretär
    1st Floor East Wing Ibex House
    42-47 Minories
    EC3N 1HA London
    35851070004
    LEDINGHAM CHALMERS
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Bevollmächtigter Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900003330001
    ASHTON TAYLOR, Mark
    7 Chine Farm Place
    Main Road, Knockholt
    TN14 7LG Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    7 Chine Farm Place
    Main Road, Knockholt
    TN14 7LG Sevenoaks
    Kent
    British103581840002
    BASILI, Irene Waage
    Ulriksdalen 35
    5009 BER Bergen
    Norway
    Geschäftsführer
    Ulriksdalen 35
    5009 BER Bergen
    Norway
    NorwayNorwegian124950210001
    BUCHAN, Peter Bruce
    44 Nadine Street
    SE7 7PG London
    Geschäftsführer
    44 Nadine Street
    SE7 7PG London
    United KingdomBritish31914980001
    HUMPHRIES, David Ian
    7 Ennismore Avenue,
    GU1 1SP Guildford
    The White House,
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Ennismore Avenue,
    GU1 1SP Guildford
    The White House,
    Surrey
    EnglandBritish130393040001
    KLOHS, Hans Petter Amundsen
    Nubbebakken 15
    FOREIGN 5018 Bergen
    Norway
    Geschäftsführer
    Nubbebakken 15
    FOREIGN 5018 Bergen
    Norway
    NorwayNorwegian115342660001
    OVSTHUS, Arnstein
    Vestre Solheia 29
    5251 Soreidgrend
    Norway
    Geschäftsführer
    Vestre Solheia 29
    5251 Soreidgrend
    Norway
    NorwayNorwegian109011500001
    RONG, Sven
    Dale
    5337 Rong
    Norway
    Geschäftsführer
    Dale
    5337 Rong
    Norway
    Norwegian109011780001
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Geschäftsführer
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    42504200004

    Hat ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Ship mortgage deed
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 15. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    An amount of USD360,000,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel being the M.V. geo atlantic, comprising of various parts and appurtenances, together with the proceeds of all insurance sums. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 28. Aug. 2007
    Geliefert am 18. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its respective right title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of earnings
    Erstellt am 28. Aug. 2007
    Geliefert am 18. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The earnings being all moneys whatsoever from time to time due or payable to the assignor arising out of the use or operation of the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Account pledge
    Erstellt am 30. März 2006
    Geliefert am 20. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's rights' title and interest to the amount at any time credited or deposited on the following accounts with the agent nok account no. 6501.06.54143 usd account no. 6502.04.42780 eur account no. 6503.04.47667. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 30. März 2006
    Geliefert am 20. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its respective right, title and interest in and to the insurances (including any building risk insurance during the construction of the vessel). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of earnings
    Erstellt am 30. März 2006
    Geliefert am 20. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights, title and interest to and under the earnings, the time charter and all other charterparties in respect of the vessel being M.V. "polar king" with a duration of 12 months or more. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Ship mortgage executed outside the united kingdom and comprising property situated there
    Erstellt am 23. Nov. 2005
    Geliefert am 02. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    M.V. polar king the vessels various parts and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 23. Nov. 2005
    Geliefert am 02. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights, earnings and the bareboat charter. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Account pledge
    Erstellt am 23. Nov. 2005
    Geliefert am 02. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The amoumt at any time credited or deposited on the following accounts, nok account no 6501.06.54143. usd account no 6502.04.42780. eur account no 6503.04.47667. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 23. Nov. 2005
    Geliefert am 02. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The insurances.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Norge Asa
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ARROW SEISMIC INVEST I LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Juni 2010Beginn der Liquidation
    04. Sept. 2013Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven John Parker
    One Euston Square 40 Melton Street
    W1U 6RD London
    Praktiker
    One Euston Square 40 Melton Street
    W1U 6RD London
    Trevor John Binyon
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London
    Praktiker
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0