ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED

ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05617735
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ramtech House Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis09. Nov. 2024

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2024 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Alan Christopher Middup als Geschäftsführer am 17. Okt. 2024

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Oliver Paul Simon Murray als Direktor am 29. Juli 2024

    2 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung am 19. Juli 2024

    • Kapital: GBP 1,000
    5 SeitenSH19

    legacy

    6 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancel cpital redemption reserve 18/07/2024
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share consolidation 27/06/2024
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    7 SeitenMA

    Aktienkonsolidierung am 27. Juni 2024

    6 SeitenSH02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Consolidation of shares 29/05/2024
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    7 SeitenMA

    Aktienkonsolidierung am 29. Mai 2024

    6 SeitenSH02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2023

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Giorgio Koursaris als Geschäftsführer am 10. März 2023

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2022

    23 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Miles Hicks als Geschäftsführer am 31. Dez. 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Andrew Miles Hicks als Direktor am 20. Dez. 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Giorgio Koursaris als Direktor am 20. Dez. 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Alan Christopher Middup als Direktor am 20. Dez. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Miles Hicks als Geschäftsführer am 20. Dez. 2022

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WADHIA, Aron Jayesh
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Sekretär
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    303524270001
    BUSH, Stephen Charles
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    EnglandBritish111791750001
    LOMBARD, Charles
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    ItalyFrench237791420003
    MURRAY, Oliver Paul Simon
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    EnglandBritish319423330001
    BATCHELOR, Helen Louise
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Sekretär
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    298157380001
    DINSMORE, Brian Geoffrey
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    204559580001
    FOOT, Justin Hugh
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    222780540001
    HICKS, Andrew Miles
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    214029230001
    HICKS, Andrew Miles
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Abbeyfield House
    Nottinghamshire
    201029920001
    HICKS, Andrew Miles
    40 Spinney Hill
    Melbourne
    DE73 8LX Derby
    Sekretär
    40 Spinney Hill
    Melbourne
    DE73 8LX Derby
    British108759450001
    LOWE, Nicholas William
    Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    36
    England
    Sekretär
    Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    36
    England
    British138792100001
    WATKINS, Claire Louise Blanche
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Sekretär
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    246306180001
    HICKS, Andrew Miles
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    EnglandBritish302788350001
    HICKS, Andrew Miles
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    EnglandBritish302788350001
    HICKS, Emma Jane
    40 Spinney Hill
    Melbourne
    DE73 8LX Derby
    Geschäftsführer
    40 Spinney Hill
    Melbourne
    DE73 8LX Derby
    British108759440001
    KOURSARIS, Giorgio
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    ItalyItalian281244010001
    MCMICHAEL, Anthony Terence
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Isle Of ManBritish48787310005
    MIDDUP, Alan Christopher
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    EnglandBritish303524690001
    WATKINS, Claire Louise Blanche
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Geschäftsführer
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    EnglandBritish207730520001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASHTON LISTER INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Rectory Way
    HP7 0DE Amersham
    Misbourne Court
    Buckinghamshire
    England
    29. Juli 2021
    Rectory Way
    HP7 0DE Amersham
    Misbourne Court
    Buckinghamshire
    England
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer00040932
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Mr Anthony Terence Mcmichael
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    06. Apr. 2016
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Isle Of Man
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Andrew Miles Hicks
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    06. Apr. 2016
    Castlebridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Ramtech House
    England
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0