CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05653475 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Valhalla House 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Northamptonshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROOMCO (3981) LIMITED | 14. Dez. 2005 | 14. Dez. 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Colin John French als Direktor am 14. Juli 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of Peter Nichols as a person with significant control on 19. Juni 2020 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of John James Michael Fields as a person with significant control on 19. Juni 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von John James Michael Fields als Geschäftsführer am 19. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von John James Michael Fields als Sekretär am 19. Juni 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Peter Nichols als Direktor am 17. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of John James Fields as a person with significant control on 31. März 2017 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of Peter Nichols as a person with significant control on 31. März 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von Peter Nichols als Geschäftsführer am 31. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENCH, Colin John | Sekretär | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire England | British | 86618080001 | ||||||
| FRENCH, Colin John | Geschäftsführer | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire | United Kingdom | British | 86618080002 | |||||
| NICHOLS, Peter | Geschäftsführer | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire | United Kingdom | British | 45119740003 | |||||
| FIELDS, John James Michael | Sekretär | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire England | British | 137625640001 | ||||||
| JAMES, Stephen | Sekretär | 9a De Montfort Road CV8 1DF Kenilworth Warwickshire | British | 79633850001 | ||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||
| FIELDS, John James Michael | Geschäftsführer | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire England | England | British | 137625640001 | |||||
| JAMES, Stephen | Geschäftsführer | 9a De Montfort Road CV8 1DF Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | 79633850001 | |||||
| NICHOLS, Kathryn Ann | Geschäftsführer | Moors Farm West Farndon NN11 3TX Daventry Northamptonshire | England | British | 57427400002 | |||||
| NICHOLS, Peter | Geschäftsführer | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire England | United Kingdom | British | 45119740003 | |||||
| DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146610002 | |||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Peter Nichols | 19. Juni 2020 | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr John James Michael Fields | 31. März 2017 | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Peter Nichols | 06. Apr. 2016 | 30 Ashby Road NN12 6PG Towcester Valhalla House Northamptonshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat CHANCERY NOMINEES (COBALT TWO) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 17. Feb. 2006 Geliefert am 22. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of various agreement | Erstellt am 17. Feb. 2006 Geliefert am 22. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, the borrowers and the sydicate to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest in and to the charged agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Feb. 2006 Geliefert am 22. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, the borrowers and the syndicate to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property situate and k/a building d cobalt south cobalt business park north tyneside all benefits in respect of the insurances and all clims all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0