NORPRINT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORPRINT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05665731
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORPRINT LIMITED?

    • Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich NORPRINT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORPRINT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WILLOUGHBY (534) LIMITED04. Jan. 200604. Jan. 2006

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORPRINT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORPRINT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2020

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2019

    30 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2018

    27 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    18 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    27 SeitenAM22

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    26 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Dez. 2016

    33 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    29 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Juni 2016

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Jan. 2016

    22 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B

    15 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    32 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Horncastle Road Boston Lincolnshire PE21 9HZ zum Mazars House Gelderd Road Gildersome Leeds Yorkshire LS27 7JN am 17. Aug. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von NORPRINT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Sekretär
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    British130150960001
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritish152573210001
    COLCLOUGH, Roy Harry
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    EnglandBritish56053020001
    JOHNSON, Paul Rowland
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritish71509040002
    LAIDLAW, Alan
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritish65449270007
    WISE, John Robert
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritish149016400001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Sekretär
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    British121161680001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Sekretär
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    68522760005
    DOVE, Nicholas Charles
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritish107550720001
    FAWDINGTON, Eric Alexander
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    EnglandBritish59580130001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    British121161680001
    FRENCH, Nicholas Gordon
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritish71509080001
    SEN, Jaidip
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    EnglandBritish136029390001
    SHOOTER, Michael William
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritish66802990002
    WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Geschäftsführer
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    95689040001

    Hat NORPRINT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. Dez. 2013
    Geliefert am 17. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 22. Aug. 2012
    Geliefert am 29. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Nortag dynamic rf/rfid security tag laminator serial no M677 (rebuilt 2005), mark andy 4150-16B 16" 4 colour flexopress converter serial no 1005580 (1998) and mark andy norprint po washer tag converter serial no 061102 (for full list of mortgaged chattels please see form MG01) fixed charge all plant and machinery and the benefit of all rights and claims in respect of the design construction repair or replacement of the same see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Erstellt am 22. Aug. 2012
    Geliefert am 29. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Bank Limited
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Erstellt am 22. Aug. 2012
    Geliefert am 29. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2011
    Geliefert am 04. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2010
    Geliefert am 03. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all plant and machinery being- arsoma EM410 8 colour flexopress printing line s/no 410-293. arsoma EM410 13 station modular litho/flexopress printing line s/no 410-218. additional interchangeable modules including 3 x 24" litho printing heads (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 03. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 16. Apr. 2010
    Geliefert am 23. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fised charges all its plant and machinery,the benefit of all the company's rights and claims,the benefits arising under the policies see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 16. Apr. 2010
    Geliefert am 23. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • G E Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 31. Jan. 2008
    Geliefert am 06. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £150,000.00 in a seprate interest-earning deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Norcros Estates Limited
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 04. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2006
    Geliefert am 15. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited and magnadata group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Securities Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2006
    Geliefert am 14. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat NORPRINT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Juli 2015Beginn der Verwaltung
    22. Juli 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Patrick Alexander Lannagan
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Praktiker
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    2
    DatumTyp
    22. Juli 2017Beginn der Liquidation
    23. Juni 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Patrick Alexander Lannagan
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Praktiker
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Conrad Alexander Pearson
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Praktiker
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0