NORPRINT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NORPRINT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05665731 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NORPRINT LIMITED?
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich NORPRINT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Mazars House Gelderd Road Gildersome LS27 7JN Leeds Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NORPRINT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WILLOUGHBY (534) LIMITED | 04. Jan. 2006 | 04. Jan. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORPRINT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NORPRINT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 20 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2020 | 21 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2019 | 30 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2018 | 27 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 18 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 27 Seiten | AM22 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 26 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Dez. 2016 | 33 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators | 1 Seiten | 2.40B | ||||||||||
Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator | 29 Seiten | 2.39B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Juni 2016 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Jan. 2016 | 22 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 15 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 32 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Horncastle Road Boston Lincolnshire PE21 9HZ zum Mazars House Gelderd Road Gildersome Leeds Yorkshire LS27 7JN am 17. Aug. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NORPRINT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPION, David Neil | Sekretär | Gelderd Road Gildersome LS27 7JN Leeds Mazars House Yorkshire | British | 130150960001 | ||||||
| CHAMPION, David Neil | Geschäftsführer | Gelderd Road Gildersome LS27 7JN Leeds Mazars House Yorkshire | United Kingdom | British | 152573210001 | |||||
| COLCLOUGH, Roy Harry | Geschäftsführer | Gelderd Road Gildersome LS27 7JN Leeds Mazars House Yorkshire | England | British | 56053020001 | |||||
| JOHNSON, Paul Rowland | Geschäftsführer | Gelderd Road Gildersome LS27 7JN Leeds Mazars House Yorkshire | United Kingdom | British | 71509040002 | |||||
| LAIDLAW, Alan | Geschäftsführer | Gelderd Road Gildersome LS27 7JN Leeds Mazars House Yorkshire | United Kingdom | British | 65449270007 | |||||
| WISE, John Robert | Geschäftsführer | Gelderd Road Gildersome LS27 7JN Leeds Mazars House Yorkshire | United Kingdom | British | 149016400001 | |||||
| FRAY, Timothy John | Sekretär | 49 Stamford Drive Groby LE6 0YD Leicester Leicestershire | British | 121161680001 | ||||||
| WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Cumberland Court 80 Mount Street NG1 6HH Nottingham | 68522760005 | |||||||
| DOVE, Nicholas Charles | Geschäftsführer | Horncastle Road Boston PE21 9HZ Lincolnshire | United Kingdom | British | 107550720001 | |||||
| FAWDINGTON, Eric Alexander | Geschäftsführer | Horncastle Road Boston PE21 9HZ Lincolnshire | England | British | 59580130001 | |||||
| FRAY, Timothy John | Geschäftsführer | 49 Stamford Drive Groby LE6 0YD Leicester Leicestershire | British | 121161680001 | ||||||
| FRENCH, Nicholas Gordon | Geschäftsführer | 6 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | United Kingdom | British | 71509080001 | |||||
| SEN, Jaidip | Geschäftsführer | Brinkhall Way Welton LN2 3NS Lincoln 25 Lincolnshire | England | British | 136029390001 | |||||
| SHOOTER, Michael William | Geschäftsführer | Horncastle Road Boston PE21 9HZ Lincolnshire | United Kingdom | British | 66802990002 | |||||
| WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED | Geschäftsführer | 80 Mount Street NG1 6HH Nottingham | 95689040001 |
Hat NORPRINT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 05. Dez. 2013 Geliefert am 17. Dez. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 22. Aug. 2012 Geliefert am 29. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Nortag dynamic rf/rfid security tag laminator serial no M677 (rebuilt 2005), mark andy 4150-16B 16" 4 colour flexopress converter serial no 1005580 (1998) and mark andy norprint po washer tag converter serial no 061102 (for full list of mortgaged chattels please see form MG01) fixed charge all plant and machinery and the benefit of all rights and claims in respect of the design construction repair or replacement of the same see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite all assets guarantee and indemnity | Erstellt am 22. Aug. 2012 Geliefert am 29. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite all assets guarantee and indemnity | Erstellt am 22. Aug. 2012 Geliefert am 29. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite all assets guarantee and indemnity and debenture | Erstellt am 28. Apr. 2011 Geliefert am 04. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 30. Juni 2010 Geliefert am 03. Juli 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge on all plant and machinery being- arsoma EM410 8 colour flexopress printing line s/no 410-293. arsoma EM410 13 station modular litho/flexopress printing line s/no 410-218. additional interchangeable modules including 3 x 24" litho printing heads (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 16. Apr. 2010 Geliefert am 23. Apr. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fised charges all its plant and machinery,the benefit of all the company's rights and claims,the benefits arising under the policies see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite all assets guarantee and indemnity and debenture | Erstellt am 16. Apr. 2010 Geliefert am 23. Apr. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 31. Jan. 2008 Geliefert am 06. Feb. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £150,000.00 in a seprate interest-earning deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Apr. 2006 Geliefert am 04. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Jan. 2006 Geliefert am 15. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited and magnadata group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite all assets guarantee and debenture | Erstellt am 30. Jan. 2006 Geliefert am 14. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NORPRINT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0