HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05686784 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Huntington House Jockey Lane YO32 9XW Huntington York |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark John Dinnes als Geschäftsführer am 31. Jan. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 3 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Keven David Parker als Direktor am 01. Dez. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas John Child als Geschäftsführer am 31. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Caroline Scott als Direktor am 18. Okt. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark John Dinnes am 06. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark John Dinnes am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas John Child am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Caroline Scott am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 21 Seiten | 395 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOTT, Caroline | Sekretär | Huntington House Jockey Lane YO32 9XW Huntington York | British | 97248700001 | ||||||
| PARKER, Keven David | Geschäftsführer | Huntington House Jockey Lane YO32 9XW Huntington York | England | British | 163157390001 | |||||
| SCOTT, Caroline | Geschäftsführer | Huntington House Jockey Lane YO32 9XW Huntington York | England | British | 97248700001 | |||||
| C & M SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | PO BOX 55 7 Spa Road SE16 3QP London | 900007640001 | |||||||
| CHILD, Nicholas John | Geschäftsführer | Huntington House Jockey Lane YO32 9XW Huntington York | England | British | 146660790001 | |||||
| DINNES, Mark John | Geschäftsführer | Huntington House Jockey Lane YO32 9XW Huntington York | England | British | 57187600007 | |||||
| WHITEHOUSE, Stuart Richard | Geschäftsführer | The Lowlands 51 Kidderminster Road Hagley DY9 0PZ Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 97361400001 | |||||
| C & M REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | PO BOX 55 7 Spa Road SE16 3QP London | 900007630001 |
Hat HARBOUR GATE PORTSMOUTH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 27. Aug. 2009 Geliefert am 10. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of transaction security to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. Jan. 2009 Geliefert am 08. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings at raymarine hq portsmouth t/nos PM11728 PM2938 and HP300077 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of security | Erstellt am 14. Mai 2008 Geliefert am 16. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The agreements and all rights contained therein and all monies and benefits from time to time see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of security | Erstellt am 07. Mai 2008 Geliefert am 09. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right, title and interest in and to the agreements and all rights contained therein see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Mai 2008 Geliefert am 09. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0