ASDL.1 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ASDL.1 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05707948 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASDL.1 LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ASDL.1 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Henry Wood House 2 Riding House Street W1W 7FA London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASDL.1 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ARUNDEL SQUARE DEVELOPMENTS.1 LIMITED | 13. Feb. 2006 | 13. Feb. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASDL.1 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASDL.1 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Armand De Blaby als Direktor am 10. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeffrey William Adams als Geschäftsführer am 10. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom One Southampton Street London WC2R 0LR zum Henry Wood House 2 Riding House Street London W1W 7FA am 15. März 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Stonley als Geschäftsführer am 02. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Kevin Barry Duggan als Direktor am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom United House Goldsel Road Swanley BR8 8EX zum One Southampton Street London WC2R 0LR am 13. Feb. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jeffrey William Adams am 31. Mai 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Stonley am 01. Juli 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Stonley am 08. März 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jeffrey William Adams am 08. März 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elaine Driver als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASDL.1 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETT, David Melvyn | Geschäftsführer | Chepstow Villas W11 2QX London 54 | United Kingdom | British | Director | 39132210004 | ||||
DE BLABY, Richard Armand | Geschäftsführer | 2 Riding House Street W1W 7FA London Henry Wood House United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 109841060001 | ||||
DUGGAN, Kevin Barry | Geschäftsführer | 2 Riding House Street W1W 7FA London Henry Wood House United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 5330260003 | ||||
PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Geschäftsführer | 17 Greenfield Drive Fortes Green N2 9AF London | England | British | Director | 46176700002 | ||||
DRIVER, Elaine Anne | Sekretär | 134 Lennard Road BR3 1QP Beckenham Kent | British | 97041650002 | ||||||
ADAMS, Jeffrey William | Geschäftsführer | 2 Riding House Street W1W 7FA London Henry Wood House United Kingdom | United Kingdom | British | Group Chief Executive | 3480850002 | ||||
BERG, Simon Mark | Geschäftsführer | 12 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Director | 66989000001 | ||||
HINDLE, John David | Geschäftsführer | The Orchard Penshurst Road, Speldhurst TN3 0PJ Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 8481880003 | ||||
STONLEY, Nicholas | Geschäftsführer | WC2R 0LR London One Southampton Street United Kingdom | England | British | Director | 129775190003 |
Hat ASDL.1 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 27. Apr. 2009 Geliefert am 07. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a blocks b c d e and f arundel square and substructure under blocks a r b c d e f and g at arundel square islington london and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Apr. 2009 Geliefert am 08. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property blocks b,c,d,e and f arundel square and structure under blocks a,r,b,c,d,e,f and g at arundel square islington london fixed charge on the property other interests chattels goodwill insurance proceeeds the associated rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Apr. 2008 Geliefert am 12. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by a chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H all that property at arundel square london t/no NGL816116 and f/h all that property at arundel square london t/nos 100929 and NGL769599 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0