VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05710447 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Bau von sonstigen Bauingenieurprojekten n.a. (42990) / Bauwesen
Wo befindet sich VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o MRS B BREEZE CLULOW BOOKKEEPING & FORENSIC SERVICES Suite 7 Brookside House Spring Rd LE67 6LR Ibstock Leicestershire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2015 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mrs B Breeze Clulow Bookkeeping & Forensic Services Suite 3 Brookside House Spring Road Ibstock Leicestershire LE67 6LR zum C/O Mrs B Breeze Clulow Bookkeeping & Forensic Services Suite 7 Brookside House Spring Rd Ibstock Leicestershire LE67 6LR am 10. März 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 057104470006 | 38 Seiten | MR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Lyndhurst 1 Cranmer Street Long Eaton Nottingham Nottinghamshire NG10 1NJ* am 20. Juni 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Andrew Draper am 25. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Donna Draper als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Donna Draper als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Donna Louise Draper am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Donna Lousie Draper am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Andrew Draper am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAPER, Mark Andrew | Geschäftsführer | Queensway Castle Donington DE74 2XQ Derby 50 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 111459790003 | ||||
| DRAPER, Donna Louise | Sekretär | The Hollies Pear Tree Close DE74 2JJ Castle Donington Derbyshire | British | Director | 111190010002 | |||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900015000001 | |||||||
| DRAPER, Donna Louise | Geschäftsführer | The Hollies Pear Tree Close DE74 2JJ Castle Donington Derbyshire | United Kingdom | British | Director | 111190010002 | ||||
| JOWETT, Richard | Geschäftsführer | 3 Russley Road Bramcote NG9 3JF Nottingham | England | British | Director | 268137750001 | ||||
| JOWETT, Toni Marie | Geschäftsführer | 3 Russley Road Bramcote NG9 3JF Nottingham | British | Director | 111190090002 | |||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900014990001 |
Hat VOGUE DEVELOPMENTS (MIDLANDS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 06. Aug. 2013 Geliefert am 12. Aug. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings at the back of 50 victoria avenue borrowash derbyshire t/no.DY398456. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 20. Aug. 2009 Geliefert am 28. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 10156182 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Juli 2009 Geliefert am 22. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 85 nottingham rd borrowash derbyshire t/no DY49347. Any other interest in the property, all rents receivable from any lease granted out of the property and the proceeds of any insurance affecting the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Okt. 2006 Geliefert am 07. Nov. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 50 victoria avenue, borrowash, derbyshire and land to the east. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Sept. 2006 Geliefert am 13. Sept. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 2006 Geliefert am 11. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as 50 victoria avenue (and land to the east) borrowash derbyshire t/n DY398456 and DY225720, goodwill, fixtures and other equipment, rental or other income from leases,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0