UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED

UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameUNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05728623
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Nov. 2020

    12 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Nov. 2019

    11 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Nov. 2018

    12 SeitenLIQ03

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    Seiten4.70

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Europa House 20 Esplanade Scarborough Yorkshire YO11 2AQ zum 82 st John Street London EC1M 4JN am 08. Aug. 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in freiwilliger Mitgliederliquidation

    2 SeitenREST-MVL

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Nov. 2015

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    9 Seiten4.70

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Charles Mccabe am 06. März 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. März 2015

    Kapitalaufstellung am 03. März 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2014

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. März 2014

    Kapitalaufstellung am 20. März 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Charles Mccabe am 16. Sept. 2013

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2013

    16 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Sekretär
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director151895310001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDevelopment Executive154915110001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer6133267
    123430390001
    SNR DENTON SECRETARIES LIMITED
    One Fleet Place
    Cliffords Inn
    EC4M 7WS London
    Sekretär
    One Fleet Place
    Cliffords Inn
    EC4M 7WS London
    98515470002
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Sekretär
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BIRCH, Trevor Nigel
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive136579440001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Geschäftsführer
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritishFinance Director Designate118147580002
    HARROP, David Anthony
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccountant160187290001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Geschäftsführer
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritishChief Executive111427410006
    TANDY, Didier Michel
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    DWS DIRECTORS LTD
    One Fleet Place
    EC4M 7WS London
    Geschäftsführer
    One Fleet Place
    EC4M 7WS London
    111005580001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    123430390001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Hat UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 25. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    211-215 lower richmond road, richmond, t/no: SGL154462 and SY207009 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 25. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each guarantor and the company to the refinancing fee beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    211-215 lower richmond road richmond t/nos. SGL154462 and SY207009 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Refinancing Fee Beneficiary
    Transaktionen
    • 25. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2006
    Geliefert am 19. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Apr. 2006
    Geliefert am 19. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 211 to 217 lower richmond road t/no's SGL154462 and SY207009. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat UNITED SCARBOROUGH ESTATES (RICHMOND) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Nov. 2015Beginn der Liquidation
    08. März 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Stephen Elliot Solomons
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praktiker
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Andrew James Pear
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praktiker
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0