NENPLAS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NENPLAS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05743422 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NENPLAS LIMITED?
- Herstellung von anderen Kunststoffwaren (22290) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich NENPLAS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NENPLAS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HOMELUX NENPLAS LIMITED | 15. März 2006 | 15. März 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NENPLAS LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NENPLAS LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Feb. 2026 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. Feb. 2026 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Feb. 2025 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für NENPLAS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 32 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 34 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Paul Jones als Geschäftsführer am 21. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Darren James Crossley als Direktor am 21. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 32 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 35 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 30 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Jones am 12. Feb. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Beendigung der Bestellung von Robert James Butcher als Geschäftsführer am 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 31 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Lumb als Geschäftsführer am 04. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Lumb als Sekretär am 04. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 33 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Nenplas Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 32 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 5 teilweise | 1 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von NENPLAS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSLEY, Darren James | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | Commercial Director | 308193190001 | ||||
HORROBIN, Gary | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | Operations Director | 113410550002 | ||||
EMERY, Alan Michael | Sekretär | 202 Castle Hill Road Stonnall WS9 9DB Walsall West Midlands | British | Director | 40758670001 | |||||
LUMB, Richard Anthony | Sekretär | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | British | Finance Director | 82181660001 | |||||
WILLIAMS, Calvin Brett | Sekretär | Westgate 54 Sandy Road Norton DY8 3AH Stourbridge West Midlands | British | Finance Director | 71823560003 | |||||
PHILSEC LIMITED | Sekretär | No 1 Colmore Square B4 6AA Birmingham West Midlands | 100887680001 | |||||||
BUTCHER, Robert James | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | England | British | Managing Director | 113410640001 | ||||
COLLIS, Mike | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | England | British | Director | 177951560001 | ||||
EMERY, Alan Michael | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | England | British | Director | 40758670001 | ||||
FERGUSON, Andrew Robert | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | England | British | Venture Capitalist | 116262420001 | ||||
JONES, Stephen Paul | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | England | British | Director | 170770520001 | ||||
LUMB, Richard Anthony | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | England | British | Finance Director | 82181660001 | ||||
QUIRKE, Ann Elizabeth | Geschäftsführer | Airfield Industrial Estate Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Derbyshire | England | British | Sales Director | 113410520001 | ||||
WILLIAMS, Calvin Brett | Geschäftsführer | Westgate 54 Sandy Road Norton DY8 3AH Stourbridge West Midlands | England | British | Finance Director | 71823560003 | ||||
MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED | Geschäftsführer | No 1 Colmore Square B4 6AA Birmingham West Midlands | 105068630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NENPLAS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surteco Se | 06. Apr. 2016 | Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen 2 Germany | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Nenplas Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Blenheim Road DE6 1HA Ashbourne Airfield Industrial Estate England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0