GABBRO PRECISION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GABBRO PRECISION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05744593 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GABBRO PRECISION LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GABBRO PRECISION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory 110 Cannon Street EC4N 6EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GABBRO PRECISION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ESS STEELS HOLDINGS LIMITED | 10. Aug. 2006 | 10. Aug. 2006 |
| HLW 288 LIMITED | 15. März 2006 | 15. März 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GABBRO PRECISION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GABBRO PRECISION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 28 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 25 Seiten | AM10 | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 5 Seiten | AM07 | ||
Vorschlag des Verwalters | 65 Seiten | AM03 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Baird Capital Bcpe Finsbury Circus London Uk EC2M 7EB England zum C/O Frp Advisory 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 18. Apr. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Ernennung von Mr Dennis John Hall als Direktor am 28. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Deane Vincent Wakeling als Geschäftsführer am 17. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Finsbury Circus London EC2M 7EB England zum Baird Capital Bcpe Finsbury Circus London Uk EC2M 7EB am 13. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Distington House 26 Atlas Way Sheffield South Yorkshire S4 7QQ England zum 15 Finsbury Circus London EC2M 7EB am 13. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Douglas Young als Sekretär am 06. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Douglas Young als Sekretär am 09. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip David Jackson als Sekretär am 09. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Eintragung der Belastung 057445930015, erstellt am 25. März 2018 | 25 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2017 | 31 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Philip David Jackson als Sekretär am 01. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Gareth Lloyd Roberts als Geschäftsführer am 31. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip Dennison Barker als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Phillip Barker als Sekretär am 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Victoria Works 31 Catley Road Darnall Sheffield South Yorkshire S9 5JF zum Distington House 26 Atlas Way Sheffield South Yorkshire S4 7QQ am 07. Sept. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Paul Matthews als Geschäftsführer am 30. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Gareth Lloyd Roberts als Direktor am 01. Dez. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von GABBRO PRECISION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRASS, David John | Geschäftsführer | Birkett Way HP8 4BJ Chalfont St. Giles 43 Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 146153930001 | |||||
| HALL, Dennis John | Geschäftsführer | Finsbury Circus EC2M 7EB London 15 United Kingdom | United Kingdom | British | 236730040001 | |||||
| BARKER, Phillip | Sekretär | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | 157605680001 | |||||||
| FELLS, Rebecca Louise | Sekretär | 31b Chelsea Road S11 9BQ Sheffield South Yorkshire | British | 102537790001 | ||||||
| HORNE, Steven | Sekretär | Gothic Lodge Compstall Road Romiley SK6 4JG Stockport | British | 53716740003 | ||||||
| JACKSON, Philip David | Sekretär | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | 238645300001 | |||||||
| KEIGHLEY, Richard Nicholas | Sekretär | Main Street Saxby-All-Saints DN20 0QB Brigg Park View 48 North Lincolnshire | British | 137305900001 | ||||||
| YOUNG, Douglas | Sekretär | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | 245093060001 | |||||||
| BARKER, Philip Dennison | Geschäftsführer | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | United Kingdom | British | 40070580001 | |||||
| HORNE, Steven | Geschäftsführer | Gothic Lodge Compstall Road Romiley SK6 4JG Stockport | England | British | 53716740003 | |||||
| KEIGHLEY, Richard Nicholas | Geschäftsführer | Main Street Saxby-All-Saints DN20 0QB Brigg Park View 48 North Lincolnshire | England | British | 137305900001 | |||||
| KIRKHAM, Philip David | Geschäftsführer | Lime Spinney Somersall Close Somersall S40 3SG Chesterfield Derbyshire | England | British | 13484340002 | |||||
| MATTHEWS, Simon Paul | Geschäftsführer | 31 Catley Road Darnall S9 5JF Sheffield Victoria Works, U.K. | England | British | 129974940002 | |||||
| MILLER, Alexander | Geschäftsführer | 5 Kendal Drive Dronfield Woodhouse S18 8NA Dronfield Derbyshire | British | 89360780001 | ||||||
| MILNER, Duncan Paul | Geschäftsführer | Woolley Park Woolley WF4 2JS Wakefield Home Farm West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 127796890002 | |||||
| ROBERTS, Gareth Lloyd | Geschäftsführer | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | England | British | 80529150001 | |||||
| SMITH, Paul Jeremy, Dr | Geschäftsführer | Victoria Works 31 Catley Road Darnall S9 5JF Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 74597100001 | |||||
| WAKELING, Deane Vincent | Geschäftsführer | 31 Catley Road Darnall S9 5JF Sheffield Victoria Works, United Kingdom | England | British | 36941630007 | |||||
| HLW COMMECIAL LAWYERS LLP | Geschäftsführer | Princess House 122 Queen Street S1 2DW Sheffield South Yorkshire | 111476110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GABBRO PRECISION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabbro Precision Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 31 Catley Road S9 5JF Sheffield Victoria Works United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GABBRO PRECISION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 25. März 2018 Geliefert am 09. Apr. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 23. Mai 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 23. Mai 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 23. Mai 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 23. Mai 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 21. Dez. 2015 Geliefert am 23. Dez. 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2015 Geliefert am 14. Juli 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of gabbro precision limited. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Shares pledge | Erstellt am 08. Aug. 2012 Geliefert am 15. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The shares- 10,000 ordinary shares of £1.00 each with a nominal value of £10,000 in nexus precision engineering limited see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage over stocks, shares and collective investment schemes | Erstellt am 08. Aug. 2012 Geliefert am 15. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The stocks, shares and other marketable securities- 1,000 ordinary shares of £1 each in midland precision limited see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage over shares | Erstellt am 18. Dez. 2007 Geliefert am 03. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 63,062 ordinary shares of £1 each in engineering special steels limited, 1,000 ordinary shares of £1 each in sheffield deep bore limited and 12,000 ordinary shares of £1 each in ancon special alloy steels limited together with all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Dez. 2007 Geliefert am 03. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Napier works greasbrough street rotherham t/no SYK437265. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Dez. 2007 Geliefert am 03. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Juni 2006 Geliefert am 24. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit D1 to D5 greasbrough street rotherham south yorkshire t/no SYK437265. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Juni 2006 Geliefert am 24. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 31 catley road sheffield south yorkshire SYK276841. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 2006 Geliefert am 24. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GABBRO PRECISION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0