GABBRO PRECISION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGABBRO PRECISION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05744593
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GABBRO PRECISION LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich GABBRO PRECISION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Frp Advisory
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GABBRO PRECISION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ESS STEELS HOLDINGS LIMITED10. Aug. 200610. Aug. 2006
    HLW 288 LIMITED15. März 200615. März 2006

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GABBRO PRECISION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für GABBRO PRECISION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    28 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    25 SeitenAM10

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    5 SeitenAM07

    Vorschlag des Verwalters

    65 SeitenAM03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Baird Capital Bcpe Finsbury Circus London Uk EC2M 7EB England zum C/O Frp Advisory 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 18. Apr. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Ernennung von Mr Dennis John Hall als Direktor am 28. Feb. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Deane Vincent Wakeling als Geschäftsführer am 17. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Finsbury Circus London EC2M 7EB England zum Baird Capital Bcpe Finsbury Circus London Uk EC2M 7EB am 13. Aug. 2018

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Distington House 26 Atlas Way Sheffield South Yorkshire S4 7QQ England zum 15 Finsbury Circus London EC2M 7EB am 13. Aug. 2018

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Douglas Young als Sekretär am 06. Aug. 2018

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Douglas Young als Sekretär am 09. Apr. 2018

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Philip David Jackson als Sekretär am 09. Apr. 2018

    1 SeitenTM02

    Eintragung der Belastung 057445930015, erstellt am 25. März 2018

    25 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2017

    31 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Philip David Jackson als Sekretär am 01. Okt. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Gareth Lloyd Roberts als Geschäftsführer am 31. Aug. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Philip Dennison Barker als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Phillip Barker als Sekretär am 29. Sept. 2017

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Victoria Works 31 Catley Road Darnall Sheffield South Yorkshire S9 5JF zum Distington House 26 Atlas Way Sheffield South Yorkshire S4 7QQ am 07. Sept. 2017

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Simon Paul Matthews als Geschäftsführer am 30. Apr. 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Gareth Lloyd Roberts als Direktor am 01. Dez. 2016

    3 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von GABBRO PRECISION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARRASS, David John
    Birkett Way
    HP8 4BJ Chalfont St. Giles
    43
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Birkett Way
    HP8 4BJ Chalfont St. Giles
    43
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish146153930001
    HALL, Dennis John
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    15
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    15
    United Kingdom
    United KingdomBritish236730040001
    BARKER, Phillip
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    Sekretär
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    157605680001
    FELLS, Rebecca Louise
    31b Chelsea Road
    S11 9BQ Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    31b Chelsea Road
    S11 9BQ Sheffield
    South Yorkshire
    British102537790001
    HORNE, Steven
    Gothic Lodge
    Compstall Road Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Sekretär
    Gothic Lodge
    Compstall Road Romiley
    SK6 4JG Stockport
    British53716740003
    JACKSON, Philip David
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    Sekretär
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    238645300001
    KEIGHLEY, Richard Nicholas
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    Sekretär
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    British137305900001
    YOUNG, Douglas
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    Sekretär
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    245093060001
    BARKER, Philip Dennison
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritish40070580001
    HORNE, Steven
    Gothic Lodge
    Compstall Road Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Geschäftsführer
    Gothic Lodge
    Compstall Road Romiley
    SK6 4JG Stockport
    EnglandBritish53716740003
    KEIGHLEY, Richard Nicholas
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    EnglandBritish137305900001
    KIRKHAM, Philip David
    Lime Spinney Somersall Close
    Somersall
    S40 3SG Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Lime Spinney Somersall Close
    Somersall
    S40 3SG Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish13484340002
    MATTHEWS, Simon Paul
    31 Catley Road
    Darnall
    S9 5JF Sheffield
    Victoria Works,
    U.K.
    Geschäftsführer
    31 Catley Road
    Darnall
    S9 5JF Sheffield
    Victoria Works,
    U.K.
    EnglandBritish129974940002
    MILLER, Alexander
    5 Kendal Drive
    Dronfield Woodhouse
    S18 8NA Dronfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    5 Kendal Drive
    Dronfield Woodhouse
    S18 8NA Dronfield
    Derbyshire
    British89360780001
    MILNER, Duncan Paul
    Woolley Park
    Woolley
    WF4 2JS Wakefield
    Home Farm
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Woolley Park
    Woolley
    WF4 2JS Wakefield
    Home Farm
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish127796890002
    ROBERTS, Gareth Lloyd
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    26 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Distington House
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish80529150001
    SMITH, Paul Jeremy, Dr
    Victoria Works
    31 Catley Road Darnall
    S9 5JF Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Victoria Works
    31 Catley Road Darnall
    S9 5JF Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish74597100001
    WAKELING, Deane Vincent
    31 Catley Road
    Darnall
    S9 5JF Sheffield
    Victoria Works,
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    31 Catley Road
    Darnall
    S9 5JF Sheffield
    Victoria Works,
    United Kingdom
    EnglandBritish36941630007
    HLW COMMECIAL LAWYERS LLP
    Princess House
    122 Queen Street
    S1 2DW Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Princess House
    122 Queen Street
    S1 2DW Sheffield
    South Yorkshire
    111476110001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GABBRO PRECISION LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    31 Catley Road
    S9 5JF Sheffield
    Victoria Works
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    31 Catley Road
    S9 5JF Sheffield
    Victoria Works
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimtied By Shares
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England & Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer6451211
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat GABBRO PRECISION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 25. März 2018
    Geliefert am 09. Apr. 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Mai 2016
    Geliefert am 23. Mai 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Baird Capital Partners Europe Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Mai 2016
    Geliefert am 23. Mai 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Baird Capital Partners Europe Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Mai 2016
    Geliefert am 23. Mai 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Baird Capital Partners Europe Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Mai 2016
    Geliefert am 23. Mai 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Baird Capital Partners Europe Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Dez. 2015
    Geliefert am 23. Dez. 2015
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank) (Company Number SC001111)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juni 2015
    Geliefert am 14. Juli 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of gabbro precision limited.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Baird Capital Partners Europe Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 14. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    Shares pledge
    Erstellt am 08. Aug. 2012
    Geliefert am 15. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The shares- 10,000 ordinary shares of £1.00 each with a nominal value of £10,000 in nexus precision engineering limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over stocks, shares and collective investment schemes
    Erstellt am 08. Aug. 2012
    Geliefert am 15. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The stocks, shares and other marketable securities- 1,000 ordinary shares of £1 each in midland precision limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 18. Dez. 2007
    Geliefert am 03. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    63,062 ordinary shares of £1 each in engineering special steels limited, 1,000 ordinary shares of £1 each in sheffield deep bore limited and 12,000 ordinary shares of £1 each in ancon special alloy steels limited together with all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 2007
    Geliefert am 03. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Napier works greasbrough street rotherham t/no SYK437265. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Dez. 2007
    Geliefert am 03. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 2006
    Geliefert am 24. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit D1 to D5 greasbrough street rotherham south yorkshire t/no SYK437265. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 2006
    Geliefert am 24. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 catley road sheffield south yorkshire SYK276841. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 2006
    Geliefert am 24. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GABBRO PRECISION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. März 2019Beginn der Verwaltung
    21. Apr. 2020Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alexander Iain Fraser
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Praktiker
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Thomas Campbell Maclennan
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Praktiker
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0