DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05768129 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Hangar Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield Hertfordshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LONDON & REGIONAL (HEALTH CLUBS NO.4) LIMITED | 07. Sept. 2006 | 07. Sept. 2006 |
PRECIS (2605) LIMITED | 04. Apr. 2006 | 04. Apr. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 03. Jan. 2025 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 03. Okt. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 04. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 18. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 04. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 5 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 057681290007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 057681290009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 057681290008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 057681290009, erstellt am 16. Okt. 2020 | 18 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 5 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul John Guyer als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Eintragung der Belastung 057681290008, erstellt am 21. Sept. 2018 | 73 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 057681290007, erstellt am 21. Sept. 2018 | 28 Seiten | MR01 | ||
Erfüllung der Belastung 057681290006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ian Michael Brian Harris als Geschäftsführer am 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ian Michael Brian Harris als Sekretär am 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Scott Anthony Lloyd als Geschäftsführer am 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Jan. 2018 | 5 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURROWS, Patrick James | Geschäftsführer | Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield The Hangar Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 162567940001 | ||||
HARRIS, Ian Michael Brian | Sekretär | Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield The Hangar Hertfordshire United Kingdom | British | Chartered Accountant | 116885790001 | |||||
LUCK, Richard Nigel | Sekretär | Herschel Grange Warfield RG42 6AT Bracknell 4 Berkshire | British | Company Director | 61070930001 | |||||
OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Sekretär | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||
BACKHOUSE, Nicholas Paul | Geschäftsführer | Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield The Hangar Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 64723790002 | ||||
GUYER, Paul John | Geschäftsführer | Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield The Hangar Hertfordshire United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 130981870003 | ||||
HARRIS, Ian Michael Brian | Geschäftsführer | Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield The Hangar Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 116885790001 | ||||
KING, Christopher | Geschäftsführer | 53 Kings Road TW10 6EG Richmond Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 77423330002 | ||||
LLOYD, Scott Anthony | Geschäftsführer | Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield The Hangar Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 65590160004 | ||||
LUCK, Richard Nigel | Geschäftsführer | Herschel Grange Warfield RG42 6AT Bracknell 4 Berkshire | British | Company Director | 61070930001 | |||||
PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 77973430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Next Generation Clubs Limited | 06. Apr. 2016 | Mosquito Way Hatfield Business Park AL10 9AX Hatfield The Hangar Hertfordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat DAVID LLOYD LEISURE NOMINEE NO.4 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 16. Okt. 2020 Geliefert am 25. Okt. 2020 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Full title guarantee by way of first legal mortgage of the leasehold property of beaconsfield club - odyssey glory mill, glory mill lane, wooburn green, high wycombe HP10 0BX and bristol westbury - land and buildings at the greenway centre, southmead, bristol BS10 6AZ and cambridge - land and buildings at coldham's business park, norman way, off coldham's lane, cambridge CB1 3LH and chorley - land lying to the south of moss lane, whittle-le-woods, chorley, lancashire and dartford - next generation sports club, darenth road, dartford, kent. For more details please refer to the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 21. Sept. 2018 Geliefert am 28. Sept. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 21. Sept. 2018 Geliefert am 28. Sept. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The mortgaged property being odyssey glory mill, glory mill lane, wooburn green, high wycombe, HP10 0BX with title number BM330516 and other mortgaged property specified in the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Dez. 2015 Geliefert am 14. Dez. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 01. Nov. 2013 Geliefert am 13. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Amendment deed relating to a debenture originally dated 03 june 2007 and | Erstellt am 03. Nov. 2008 Geliefert am 19. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Nov. 2008 Geliefert am 14. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture accession deed | Erstellt am 02. Aug. 2007 Geliefert am 14. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Juli 2007 Geliefert am 02. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor or the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0