ETONFIELDS GP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameETONFIELDS GP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05771240
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ETONFIELDS GP LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich ETONFIELDS GP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Castlegate House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ETONFIELDS GP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.23) LIMITED05. Apr. 200605. Apr. 2006

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ETONFIELDS GP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für ETONFIELDS GP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    15 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Feb. 2020

    20 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Feb. 2019

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Feb. 2018

    20 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Feb. 2017

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Feb. 2016

    9 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Tyburn Lane Private Equity 43-44 Albemarle Street London W1S 4JJ zum Castlegate House 36 Castle Street Hertford Hertfordshire SG14 1HH am 19. Feb. 2015

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 05. Feb. 2015

    LRESEX

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2014

    11 SeitenAA

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    8 SeitenRM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    8 SeitenRM01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 09. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2013

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Philippa Scobie als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Robert Savill als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Philippa Scobie als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2012

    11 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Philippa Scobie am 10. Okt. 2012

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Ernennung von Mrs Philippa Scobie als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von David Morgan als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von ETONFIELDS GP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SAVILL, Robert
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Sekretär
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    176203530001
    DALY, John Francis
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish78960760003
    MACALPINE, Findlay Cameron
    76 Blacketts Wood Drive
    WD3 5QQ Chorley Wood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    76 Blacketts Wood Drive
    WD3 5QQ Chorley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritish61473240003
    NEWSOME, David Francis
    9 Priory Avenue
    Eden Gate
    IRISH Delgany
    Co Wicklow
    Ireland
    Geschäftsführer
    9 Priory Avenue
    Eden Gate
    IRISH Delgany
    Co Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish157637920001
    O'HARA, Patrick
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish82724260003
    PARKER, Gordon
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish85330570006
    DUNKLEY, Philippa
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Other124641320003
    MORGAN, David Richard
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Sekretär
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    147695530001
    PARKER, Gordon
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Sekretär
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Irish85330570001
    SCOBIE, Philippa
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Sekretär
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    167237380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    Sekretär
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    111451340001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    Geschäftsführer
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    93433510001

    Hat ETONFIELDS GP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security assignment
    Erstellt am 06. Dez. 2006
    Geliefert am 12. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security assignment
    Erstellt am 06. Dez. 2006
    Geliefert am 12. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2006
    Geliefert am 12. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a as the belfry business park, colonial way, watford, hertfordshire t/n HD55936 its interest in: all existing and future fittings, plant, equipment, machinery, tools, vehicles, furniture and other tangible movable property at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2006
    Geliefert am 12. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a as the belfry business park, colonial way, watford, hertfordshire t/n HD55936 its interest in: all existing and future fittings, plant, equipment, machinery, tools, vehicles, furniture and other tangible movable property at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 102. Aug. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 1
    Security assignment
    Erstellt am 17. Okt. 2006
    Geliefert am 21. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, acting as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security assignment
    Erstellt am 17. Okt. 2006
    Geliefert am 21. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a alpha and beta house parkside court rooley lane bradford t/no WYK711270, f/h property k/a cedar and beech house manor road horsforth leeds t/no WYK607895, f/h property k/a crown house 81/89 great george street and 18 and 18A leighton street leeds t/no WYK561304 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 202. Aug. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 2
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a alpha and beta house parkside court rooley lane bradford t/no WYK711270, f/h property k/a cedar and beech house manor road horsforth leeds t/no WYK607895, f/h property k/a crown house 81/89 great george street and 18 and 18A leighton street leeds t/no WYK561304 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a leisure site 4 parkway birmingham great park west midlands t/no WM696792, f/h property k/a land on the east side of station road swinton salford greater manchester t/nos GM438354 and GM471358, f/h property k/a land on the north side of bone land newbury t/no BK282065 by way of fixed charge all fittings plant equipment machinery tools vehicles, any investment, any hedging agreement and all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a leisure site 4 parkway birmingham great park west midlands t/no WM696792, f/h property k/a land on the east side of station road swinton salford greater manchester t/nos GM438354 and GM471358, f/h property k/a land on the north side of bone land newbury t/no BK282065 by way of fixed charge all fittings plant equipment machinery tools vehicles, any investment, any hedging agreement and all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ETONFIELDS GP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kevin Peter Mersh
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Receiver Manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Matthew Richard Nagle
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Receiver Manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kevin Peter Mersh
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Receiver Manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Matthew Richard Nagle
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Receiver Manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    3
    DatumTyp
    05. Feb. 2015Beginn der Liquidation
    19. Jan. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard William James Long
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford
    Praktiker
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0