MAXIMUSE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAXIMUSE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05780633
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAXIMUSE LIMITED?

    • Dacharbeiten (43910) / Bauwesen

    Wo befindet sich MAXIMUSE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Station House
    Station Road
    DH3 3DU Chester Le Street
    County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAXIMUSE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MAXIMUSE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAXIMUSE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 29. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    12 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Graham Roy Jennings am 29. Juli 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Verschiedenes

    Sect 519
    1 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Section 519
    1 SeitenMISC

    Ernennung von Mr Graham Roy Jennings als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Steven Gray als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    12 SeitenAA

    Ernennung von Mr Steven Mark Roberts als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    13 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Wendy Ann Edgell als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Graham Forrest als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Graham Forrest als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Keith Soulsby am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Graham Stuart Lindsay Forrest am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Graham Stuart Lindsay Forrest als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von MAXIMUSE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EDGELL, Wendy Ann
    Station House
    Station Road
    DH3 3DU Chester Le Street
    County Durham
    Sekretär
    Station House
    Station Road
    DH3 3DU Chester Le Street
    County Durham
    164077240001
    JENNINGS, Graham Roy
    Station House
    Station Road
    DH3 3DU Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    Station House
    Station Road
    DH3 3DU Chester Le Street
    County Durham
    EnglandBritishDirector131949320002
    ROBERTS, Steven Mark
    Station House
    Station Road
    DH3 3DU Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    Station House
    Station Road
    DH3 3DU Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishDirector41718420002
    SOULSBY, Keith
    Laurel Court
    Pelaw
    DH2 2LY Chester Le Street
    3
    County Durham
    Geschäftsführer
    Laurel Court
    Pelaw
    DH2 2LY Chester Le Street
    3
    County Durham
    United KingdomBritishDirector121068750002
    FORREST, Graham Stuart Lindsay
    Newburn Bridge Road
    NE21 4NT Blaydon-On-Tyne
    Chirmarn Limited
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Sekretär
    Newburn Bridge Road
    NE21 4NT Blaydon-On-Tyne
    Chirmarn Limited
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    151147630001
    FORREST, Graham Stuart Lindsay
    65 Appletree Gardnes
    NE6 4PB Walkerville
    Newcastle
    Sekretär
    65 Appletree Gardnes
    NE6 4PB Walkerville
    Newcastle
    BritishDirector83309430003
    JAY, David
    Mulberry House
    Pinfold Lane Kirk
    WF8 3JT Smeaton
    Sekretär
    Mulberry House
    Pinfold Lane Kirk
    WF8 3JT Smeaton
    BritishDirector122571220001
    OSBOURNE NOMINEES TWO LIMITED
    5 Osborne Terrace
    Jesmond
    NE2 1SQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    5 Osborne Terrace
    Jesmond
    NE2 1SQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    112171850001
    FORREST, Graham Stuart Lindsay
    Elmfield Road
    Gosforth
    NE3 4BD Newcastle Upon Tyne
    66
    Geschäftsführer
    Elmfield Road
    Gosforth
    NE3 4BD Newcastle Upon Tyne
    66
    United KingdomBritishDirector125934380001
    GRAY, Steven
    Denewood
    Wooley Grange
    NE46 1TY Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Denewood
    Wooley Grange
    NE46 1TY Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector121721330001
    JAY, David
    Mulberry House
    Pinfold Lane Kirk
    WF8 3JT Smeaton
    Geschäftsführer
    Mulberry House
    Pinfold Lane Kirk
    WF8 3JT Smeaton
    EnglandBritishDirector122571220001
    PITHER, Jon Peter
    5a Selwyn Gardens
    CB3 9AX Cambridge
    Cambs
    Geschäftsführer
    5a Selwyn Gardens
    CB3 9AX Cambridge
    Cambs
    United KingdomBritishDirector96134950002
    OSBOURNE NOMINEES ONE LIMITED
    5 Osborne Terrace
    Jesmond
    NE2 1SQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    5 Osborne Terrace
    Jesmond
    NE2 1SQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    98608300001

    Hat MAXIMUSE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 01. Nov. 2007
    Geliefert am 10. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 09. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its entire right, title and interest in and to the policy; and all of its rights in relation to the policy including any right to receive any payment in relation to the policy. Policy no. 6022553, insurer: canada life, life assured: keith soulsby, sum assured: £400,000.00, date of policy: 5 may 2006.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its entire right, title and interest in and to the policy and all of its rights in relation to the policy including any right to the policy including any right to receive any payment in relation to the policy being insurer- norwich union, policy no- 36809191EW, life or lives assured- david ferguson, sum assured- £200,000 and date of policy 31 august 2006.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its entire right, title and interest in and to the policy and all of its rights in relation to the policy including any right to receive any payment in relation to the policy being insurer- norwich union, policy no- 3680193EX, life or lives assured- graham forrest, sum assured £200,000 and date of policy 13 september 2006.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2006
    Geliefert am 22. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0