MAXIMUSE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MAXIMUSE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05780633 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MAXIMUSE LIMITED?
- Dacharbeiten (43910) / Bauwesen
Wo befindet sich MAXIMUSE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Station House Station Road DH3 3DU Chester Le Street County Durham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAXIMUSE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MAXIMUSE LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MAXIMUSE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Graham Roy Jennings am 29. Juli 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Verschiedenes Sect 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Ernennung von Mr Graham Roy Jennings als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Gray als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven Mark Roberts als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Wendy Ann Edgell als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Forrest als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Forrest als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Keith Soulsby am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Graham Stuart Lindsay Forrest am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Graham Stuart Lindsay Forrest als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MAXIMUSE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGELL, Wendy Ann | Sekretär | Station House Station Road DH3 3DU Chester Le Street County Durham | 164077240001 | |||||||
JENNINGS, Graham Roy | Geschäftsführer | Station House Station Road DH3 3DU Chester Le Street County Durham | England | British | Director | 131949320002 | ||||
ROBERTS, Steven Mark | Geschäftsführer | Station House Station Road DH3 3DU Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | Director | 41718420002 | ||||
SOULSBY, Keith | Geschäftsführer | Laurel Court Pelaw DH2 2LY Chester Le Street 3 County Durham | United Kingdom | British | Director | 121068750002 | ||||
FORREST, Graham Stuart Lindsay | Sekretär | Newburn Bridge Road NE21 4NT Blaydon-On-Tyne Chirmarn Limited Tyne And Wear United Kingdom | 151147630001 | |||||||
FORREST, Graham Stuart Lindsay | Sekretär | 65 Appletree Gardnes NE6 4PB Walkerville Newcastle | British | Director | 83309430003 | |||||
JAY, David | Sekretär | Mulberry House Pinfold Lane Kirk WF8 3JT Smeaton | British | Director | 122571220001 | |||||
OSBOURNE NOMINEES TWO LIMITED | Sekretär | 5 Osborne Terrace Jesmond NE2 1SQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | 112171850001 | |||||||
FORREST, Graham Stuart Lindsay | Geschäftsführer | Elmfield Road Gosforth NE3 4BD Newcastle Upon Tyne 66 | United Kingdom | British | Director | 125934380001 | ||||
GRAY, Steven | Geschäftsführer | Denewood Wooley Grange NE46 1TY Hexham Northumberland | United Kingdom | British | Director | 121721330001 | ||||
JAY, David | Geschäftsführer | Mulberry House Pinfold Lane Kirk WF8 3JT Smeaton | England | British | Director | 122571220001 | ||||
PITHER, Jon Peter | Geschäftsführer | 5a Selwyn Gardens CB3 9AX Cambridge Cambs | United Kingdom | British | Director | 96134950002 | ||||
OSBOURNE NOMINEES ONE LIMITED | Geschäftsführer | 5 Osborne Terrace Jesmond NE2 1SQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | 98608300001 |
Hat MAXIMUSE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 01. Nov. 2007 Geliefert am 10. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of life policy | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 09. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its entire right, title and interest in and to the policy; and all of its rights in relation to the policy including any right to receive any payment in relation to the policy. Policy no. 6022553, insurer: canada life, life assured: keith soulsby, sum assured: £400,000.00, date of policy: 5 may 2006. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 03. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of life policy | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 03. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its entire right, title and interest in and to the policy and all of its rights in relation to the policy including any right to the policy including any right to receive any payment in relation to the policy being insurer- norwich union, policy no- 36809191EW, life or lives assured- david ferguson, sum assured- £200,000 and date of policy 31 august 2006. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of life policy | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 03. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its entire right, title and interest in and to the policy and all of its rights in relation to the policy including any right to receive any payment in relation to the policy being insurer- norwich union, policy no- 3680193EX, life or lives assured- graham forrest, sum assured £200,000 and date of policy 13 september 2006. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Aug. 2006 Geliefert am 22. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0