CUK CLOTHING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCUK CLOTHING LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05786280
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CUK CLOTHING LIMITED?

    • Herstellung anderer Bekleidungsstücke und Zubehör n.e.c. (14190) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich CUK CLOTHING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite A 7th Floor East West Building
    2 Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CUK CLOTHING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COURTAULDS (UK) LIMITED19. Apr. 200619. Apr. 2006

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CUK CLOTHING LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Juni 2016
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2017
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2015

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CUK CLOTHING LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis19. Apr. 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung03. Mai 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CUK CLOTHING LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CUK CLOTHING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2025

    28 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2024

    30 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2023

    39 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2022

    27 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    9 SeitenLIQ10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite a 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS zum Suite a 7th Floor East West Building 2 Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS am 07. März 2022

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    10 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2021

    19 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    6 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2020

    37 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    8 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2019

    20 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2018

    20 SeitenLIQ03

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    32 SeitenAM22

    Beendigung der Bestellung von Robert Bruce Hershan als Geschäftsführer am 25. Mai 2016

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CUK CLOTHING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHOONG, Ng Man
    8/F,
    58 Mongkok Road, Mongkok
    Kowloon
    Hong Kong
    Sekretär
    8/F,
    58 Mongkok Road, Mongkok
    Kowloon
    Hong Kong
    Malaysian112251190001
    ELLIS, Michael
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    Sekretär
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    British82849150002
    MCQUOID, Christopher
    2 Aldous Court
    SG8 7WA Fowlmere
    Sekretär
    2 Aldous Court
    SG8 7WA Fowlmere
    Irish88153100002
    SHERWIN, Michael
    42 Carisbrooke Drive
    Mapperley Park
    NG3 5DS Nottingham
    Sekretär
    42 Carisbrooke Drive
    Mapperley Park
    NG3 5DS Nottingham
    British65202240002
    WILSON, Julia Ruth
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    Sekretär
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    British73543180001
    CALCRAFT, Helen
    32 St Johns Wood Terrace
    NW8 6JL London
    Geschäftsführer
    32 St Johns Wood Terrace
    NW8 6JL London
    EnglandBritish64473810003
    CHOONG, Ng Man
    P O Box 54
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    P O Box 54
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    Nottinghamshire
    Hong KongMalaysian112251190001
    COLE, Stephen John
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    Geschäftsführer
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    EnglandBritish146475430001
    DONNELLY, David John, Mr.
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    Geschäftsführer
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    ScotlandBritish110847310002
    DONNELLY, David John, Mr.
    P O Box 54
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    P O Box 54
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    Nottinghamshire
    ScotlandBritish110847310002
    ELLIS, Michael
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    United KingdomBritish82849150002
    HERSHAN, Robert Bruce
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A 7th Floor
    Geschäftsführer
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A 7th Floor
    AustraliaAustralian112251180001
    LLEWELLYN, Stephen Michael
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    PO BOX 54
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    PO BOX 54
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish146726750001
    SEMMENS, Victor William
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    Geschäftsführer
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    EnglandBritish112730710001
    WARD, Hamish Christopher
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    Geschäftsführer
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    United KingdomNew Zealander184303620001

    Hat CUK CLOTHING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal assignment of contract monies
    Erstellt am 15. Jan. 2013
    Geliefert am 16. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 04. Dez. 2012
    Geliefert am 06. Dez. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of rent deposit
    Erstellt am 15. Dez. 2010
    Geliefert am 22. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £2,154.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Pursuant to the rent deposit deed to secure the due payment of the yearly rent, insurances rent and any sums payable under a lease see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Portman Estate Nominees (One) Limited & the Portman Estate Nominees (Two) Limited
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Sept. 2009
    Geliefert am 01. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. März 2009
    Geliefert am 14. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Jan. 2008
    Geliefert am 18. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north side of haydn road nottingham t/no NT387566 and all buildings,fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all rights,easements and privileges appurtenant to,or benefiting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 2007
    Geliefert am 16. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 16. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deposit agreement to secured own liabilities
    Erstellt am 02. Aug. 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re courtaulds (UK) LTD and numbered 0258518 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat CUK CLOTHING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Mai 2016Beginn der Verwaltung
    30. Mai 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dilip K Dattani
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praktiker
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praktiker
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    2
    DatumTyp
    30. Mai 2017Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Adrian David Allen
    Suite A 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Suite A 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Dilip K Dattani
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praktiker
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Lee Brocklehurst
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park
    LE19 1SD Enderby
    Leicestershire
    Praktiker
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park
    LE19 1SD Enderby
    Leicestershire
    Deviesh R Raikundalia
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Leicestershire
    Tyrone Courtman
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Leicestershire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0