HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05791406 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED?
- Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen
Wo befindet sich HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 54 Tower Road North Heswall CH60 6RS Wirral Merseyside United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2022 bis 30. Sept. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Gt Lingard Holdings Proprietary Limited as a person with significant control on 23. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Jenard Properties Limited as a person with significant control on 23. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hanover Buildings 11-13 Hanover Street Liverpool Merseyside L1 3DN United Kingdom zum 54 Tower Road North Heswall Wirral Merseyside CH60 6RS am 23. März 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 54 Tower Road North Heswall Wirral Merseyside CH60 6RS zum Hanover Buildings 11-13 Hanover Street Liverpool Merseyside L1 3DN am 23. März 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Fiona Jane Jenner am 15. Apr. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNER, Edward Victor | Sekretär | Tower Road North Heswall CH60 6RS Wirral 54 Merseyside United Kingdom | 160974840001 | |||||||
| JENNER, Fiona Jane | Geschäftsführer | Tower Road North Heswall CH60 6RS Wirral 54 Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 147037240002 | |||||
| LINGARD, Garry Thomas | Geschäftsführer | Cheltenham Road NSW 2119 Cheltenham 34 Australia | Australia | Australian | 113407870002 | |||||
| JONES, Howard Jeremy | Sekretär | Glasfryn Pen Y Graig Froncysyllte LL20 7RT Llangollen | British | 60571610001 | ||||||
| MIDDLEHURST, Philip | Sekretär | 2 Kenilworth Gardens WA12 8ES Warrington Cheshire | British | 98389590001 | ||||||
| JENNER, Edward Victor | Geschäftsführer | Carrig Lodge 54 Tower Road North CH60 6RS Heswall Wirral Merseyside | United Kingdom | United Kingdom | 147037230001 | |||||
| LLOYD, Robert James Winston | Geschäftsführer | Fron Farm Windmill Halkyn CH8 8EU Holywell | United Kingdom | British | 142926730001 | |||||
| MATHER, Keith Brian | Geschäftsführer | Broom Hall Barnhouse Lane Great Barrow CH3 7LA Chester | United Kingdom | British | 11964200005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gt Lingard Holdings Proprietary Limited | 23. Apr. 2018 | Inglewood Place North West Business Park Baulkham Hills 4-8 Nsw 2153 Australia | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Jenard Properties Limited | 24. Apr. 2016 | Tower Road North CH60 6RS Wirral 54 United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HAWKESBURY PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment and charge over building contract | Erstellt am 25. Jan. 2008 Geliefert am 12. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest from time to time in the charged contracts and any monies of the charged contracts or any interest in the charged contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Jan. 2008 Geliefert am 01. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and building at rugeley road hednesford staffordshire t/no SF371758 and all buildings erections,fittings and fittings,fixed plant machinery and any insurance and any proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Jan. 2008 Geliefert am 01. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge the whole of the company's undertaking and all property,assets and rights of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Aug. 2006 Geliefert am 12. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 2-8 rugleys road hednesford staffordshire t/no SF371758. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 11. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0