SPRINT 1108 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSPRINT 1108 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05792565
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SPRINT 1108 LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich SPRINT 1108 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Beauchamp Court
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPRINT 1108 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für SPRINT 1108 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Maurice Slater am 22. Mai 2020

    2 SeitenCH01

    Change of details for Mr Norman Henry Slater as a person with significant control on 22. Mai 2020

    2 SeitenPSC04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Norman Henry Slater am 22. Mai 2020

    2 SeitenCH01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Nov. 2019

    LRESSP

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019

    8 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2018 bis 30. Juni 2019

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2019 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 17. Mai 2016

    • Kapital: GBP 3
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 16. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 3
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 20 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    1 SeitenMR04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF zum 1 Beauchamp Court 10 Victors Way Barnet Hertfordshire EN5 5TZ am 17. Juli 2015

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von SPRINT 1108 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SLATER, Nicholas Maurice
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector53423100002
    SLATER, Norman Henry
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor25275530003
    WELSH, Thomas
    CM1 4DB Chelmsford
    94 Patching Hall Lane
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    CM1 4DB Chelmsford
    94 Patching Hall Lane
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector134640370001
    BRAUDE, Sheila
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    Sekretär
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    BritishDirector128788760001
    BROOKER, Wendy
    44 Merlin Grove
    BR3 3HU Beckenham
    Kent
    Sekretär
    44 Merlin Grove
    BR3 3HU Beckenham
    Kent
    British22526050001
    HURWORTH, Maureen
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    Sekretär
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    British48945190001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BRAUDE, Sheila
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    Geschäftsführer
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    EnglandBritishDirector128788760001
    HURWORTH, Maureen
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    BritishSecretary48945190001
    SLATER, Monica
    239 Regents Park Road
    N3 3LF Finchley
    Gable House
    London
    England
    Geschäftsführer
    239 Regents Park Road
    N3 3LF Finchley
    Gable House
    London
    England
    EnglandBritishDirector25275520003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SPRINT 1108 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Norman Henry Slater
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat SPRINT 1108 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 10. Okt. 2012
    Geliefert am 20. Okt. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Napoleon filling station, st helena road, bradford t/no:WYK710282 floating charge over all moveable plant machinery, implements, buildings, materials, furniture & equipment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Greenbond Properties Limited, Rapallo Limited
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2012
    Geliefert am 12. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the group members) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Star mogador filling station brighton road kingswood t/no.SY162394. Fixed charge the benefit of all agreements relating to each property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2012
    Geliefert am 12. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the group members) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Star farnham road 416 farnham road slough t/no.BK366219. Fixed charge the benefit of all agreements relating to each property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2012
    Geliefert am 12. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the group members) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Star triptons service station, whalebone lane south dagenham t/no.EGL128910, EGL255560 and EGL71655 fixed charge the benefit of all agreements relating to each property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2012
    Geliefert am 12. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the group members) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Dixon's green service station dixon's green road dudley t/no.WM541114. Fixed charge the benefit of all agreements relating to each property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2012
    Geliefert am 12. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the group members) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Star service station holdenhurst road bournemouth t/no. DT326439 and DT169192. Fixed charge the benefit of all agreements relating to each property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 2012
    Geliefert am 11. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Service station, 65 stockport road, denton t/no MAN4745 and padiham service station, burnley road, padiham, burnley t/no LAN38624 all fixtures, by way of floating charge all moveable plant, machinery,.
    Berechtigte Personen
    • Greenbond Properties Limited, Rapallo Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 20. März 2008
    Geliefert am 03. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from costen limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property at kings langley service station, 124 hempstead road, kings langley see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 2007
    Geliefert am 21. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Moor grange ring road west park leeds west yorkshire t/no WYK488684. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2007
    Geliefert am 15. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    339-345 (odd) and 347 & 349 holdenhurst road bournemouth t/no's DT326439 and DT169192. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Sept. 2007
    Geliefert am 21. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    416 farnham road slough t/n BK366219. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Sept. 2007
    Geliefert am 08. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    79 whalebone lane south dagenham land at the west side of whalebone lane south dagenham and land at the rear of triptons service station whalebone lane south dagenham t/no's EGL71655,EGL128910 and EGL244460. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 06. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the east side of brighton road kingswood t/no SY162394. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Apr. 2007
    Geliefert am 24. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Knights hill service station 260 knights hill london t/n SGL76646 and 125076. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 03. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Dixons green service station, dixons green, dudley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 03. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Napoleon filling station st helena road bradford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hayes garage wimborne road west hayes t/n DT135895 and 2 hayes lane wimborne t/n DT78592. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 2006
    Geliefert am 27. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Farnborough hill service station farnborough way orpington t/no's SGL521257 and k 141544. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Sept. 2006
    Geliefert am 22. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Scholes service station upper wortley road scholes t/no SYK233818. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Sept. 2006
    Geliefert am 22. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Padiham service station burnley road padiham burnley (t/no LA358919). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2006
    Geliefert am 20. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Service station, 65 stockport road, denton, manchester t/no MAN4745. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Sept. 2006
    Geliefert am 19. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Eldbury park service station, 290 tolladine road, worcester t/n WR92232. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2006
    Geliefert am 12. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a romsey service station, 12-16 winchester road, romsey t/no HP651807 and HP651869. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat SPRINT 1108 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Nov. 2019Beginn der Liquidation
    05. Feb. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Joylan Sunnassee
    1 Beauchamp Court Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    Herts
    Praktiker
    1 Beauchamp Court Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    Herts

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0