POSEIDON ACQUISITIONS LTD
Überblick
| Unternehmensname | POSEIDON ACQUISITIONS LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05793744 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von POSEIDON ACQUISITIONS LTD?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich POSEIDON ACQUISITIONS LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Plumtree Court 25 Shoe Lane EC4A 4AU London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von POSEIDON ACQUISITIONS LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRANDENBURG ACQUISITIONS LTD | 20. Juni 2006 | 20. Juni 2006 |
| PORTFOLIO ACQUISITIONS 3 LTD. | 25. Apr. 2006 | 25. Apr. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POSEIDON ACQUISITIONS LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für POSEIDON ACQUISITIONS LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Oliver John Bingham als Geschäftsführer am 09. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Mai 2021
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Thomas Gasson als Geschäftsführer am 16. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2020 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Kelly am 02. Sept. 2019 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Oliver John Bingham am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William Thomas Gasson am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Vikramjit Singh Chima am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Clare Charlotte Richards am 02. Sept. 2019 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Change of details for Elq Investors, Ltd as a person with significant control on 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB zum Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU am 02. Sept. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hinweis auf Beschränkungen in der Satzung der Gesellschaft | 2 Seiten | CC01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von POSEIDON ACQUISITIONS LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLY, Thomas | Sekretär | 25 Shoe Lane EC4A 4AU London Plumtree Court United Kingdom | 179912270001 | |||||||
| RICHARDS, Clare Charlotte | Sekretär | 25 Shoe Lane EC4A 4AU London Plumtree Court United Kingdom | 150043780001 | |||||||
| CHIMA, Vikramjit Singh | Geschäftsführer | 25 Shoe Lane EC4A 4AU London Plumtree Court United Kingdom | United Kingdom | Indian | 207123070001 | |||||
| BROWN, Nola Jean, Ms. | Sekretär | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 121744860001 | ||||||
| ELLIOTT, William James | Sekretär | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 56945250002 | ||||||
| RUSSELL, Nicholas David | Sekretär | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 83581360003 | ||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
| BINGHAM, Oliver John | Geschäftsführer | 25 Shoe Lane EC4A 4AU London Plumtree Court United Kingdom | United Kingdom | British | 179230260001 | |||||
| CAMPBELL II, Roy Edwin | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | United States Citizen | 100607170003 | ||||||
| COLLINS, Shaun Anthony, Mr. | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | England | British | 163985940001 | |||||
| CUTAIA, Giovanni | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | American | 100607180002 | ||||||
| DAGTOGLOU DE CARTERET, Ion Dimitris | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 89585070002 | ||||||
| DICKENS, Charlotte Elise | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | England | British | 122888200001 | |||||
| GASSON, William Thomas | Geschäftsführer | 25 Shoe Lane EC4A 4AU London Plumtree Court United Kingdom | United Kingdom | British | 108065360002 | |||||
| HALE, Jacqueline Ann | Geschäftsführer | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court | British | 138528660002 | ||||||
| HOLMES, Michael | Geschäftsführer | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | United Kingdom | British | 181558290001 | |||||
| HUNT, Susan Jane | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 50630880005 | ||||||
| MARTE, Carolina | Geschäftsführer | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court England | England | Dominican Republic | 156951830001 | |||||
| MINSON, Gregory Paul | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | United Kingdom | American,British | 100607190002 | |||||
| TAMMELA, Kimmo Benjam | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 95010560002 | ||||||
| WILTSHIRE, Jeremy Alan | Geschäftsführer | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | United Kingdom | British | 190987380001 | |||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei POSEIDON ACQUISITIONS LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elq Investors, Ltd | 15. Dez. 2016 | 25 Shoe Lane EC4A 4AU London Plumtree Court United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gs European Opportunities Fund Ii Gp Ltd | 06. Apr. 2016 | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat POSEIDON ACQUISITIONS LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| The share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there | Erstellt am 27. März 2012 Geliefert am 05. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares, being- €25,000.00 and any other shares of the company see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment agreement | Erstellt am 27. März 2012 Geliefert am 02. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and any of the other borrowers to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All actual and contingent rights and claims against the counterparty under or in connection with the reo facility agreement including claims arising from warranties representations indemnities unjust enrichment (ungerechtfertigte bereicherung) and tort (delikt) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 27. März 2012 Geliefert am 02. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the borrowers to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first floating charge all undertaking property assets and rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account pledge agreement | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 08. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any claims arising from or under the account as security and all monies and interest payable from time to time standing or accruing to the credit of the pledged account. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 08. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest present and future in and to the charged moneys and the charged accounts together with any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relating thereto. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 10. Apr. 2007 Geliefert am 25. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge over all rights,title and interest in and to the charged moneys and the charged accounts with any certificates of deposit or securities thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0