OCULAR INTEGRATION LIMITED
Überblick
Unternehmensname | OCULAR INTEGRATION LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05831231 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OCULAR INTEGRATION LIMITED?
- Sicherheitsdienstleistungen (80200) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich OCULAR INTEGRATION LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell Nottingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OCULAR INTEGRATION LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SYNECTICS SECURITY LIMITED | 02. Dez. 2020 | 02. Dez. 2020 |
QUADRANT SECURITY GROUP LIMITED | 31. Mai 2006 | 31. Mai 2006 |
NEWCO 3006 LIMITED | 30. Mai 2006 | 30. Mai 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OCULAR INTEGRATION LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Nov. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Aug. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für OCULAR INTEGRATION LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Mai 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 13. Juni 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Mai 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für OCULAR INTEGRATION LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mrs Nicola Anne Kolasa als Direktor am 01. Nov. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher James Jepson als Direktor am 01. Nov. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed synectics security LIMITED\certificate issued on 01/11/24 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 058312310007, erstellt am 09. Sept. 2024 | 16 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Anthony Webb als Geschäftsführer am 25. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 058312310006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Phillip Stringer als Geschäftsführer am 16. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2023 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lucy Holloway-Bone als Direktor am 09. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2022 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stacey Louise Anderson als Geschäftsführer am 30. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julie Town als Geschäftsführer am 30. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2021 | 34 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Amanda Louise Larnder als Direktor am 04. Juli 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Michael Bedford als Geschäftsführer am 01. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Graham Brocklesby als Geschäftsführer am 30. Nov. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2020 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Synectics Plc as a person with significant control on 01. Dez. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2019 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OCULAR INTEGRATION LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEWART, Claire Susan | Sekretär | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 255944650001 | |||||||||||
HOLLOWAY-BONE, Lucy | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Director | 314470750001 | ||||||||
JEPSON, Christopher James | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Director | 328989110001 | ||||||||
KOLASA, Nicola Anne | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Director | 232618630001 | ||||||||
LARNDER, Amanda Louise | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Director | 257818550001 | ||||||||
PENNINGTON, Mark | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Managing Director | 242318670001 | ||||||||
BESWICK, Simon | Sekretär | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 253092190001 | |||||||||||
BRIERLEY, Richard Paul | Sekretär | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | 208697610001 | |||||||||||
POULTNEY, Nigel Charles | Sekretär | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | British | 8488600002 | ||||||||||
STILWELL, Michael James | Sekretär | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | 244997180001 | |||||||||||
ANDERSON, Stacey Louise | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | United Kingdom | British | Operations Director | 134422170001 | ||||||||
BEADLE, Iain | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | United Kingdom | British | Director | 242062410001 | ||||||||
BEDFORD, David Michael | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Finance Director | 302295360001 | ||||||||
BESWICK, Simon | Geschäftsführer | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | United Kingdom | British | Finance Director | 133770010001 | ||||||||
BODDY, Michael Gordon | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | United Kingdom | British | Engineer | 80518230001 | ||||||||
BRADSHAW, Lauren Marie | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | England | British | Finance Director | 160602560001 | ||||||||
BROCKLESBY, Michael Graham | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Director | 180171770001 | ||||||||
DOYLE, Philip John Frederick | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 97851460001 | ||||||||
HARGEST, Paul Leonard | Geschäftsführer | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | England | British | Accountant | 64333640005 | ||||||||
HOWE, John Martin | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | United Kingdom | British | National Service Manager | 160895570001 | ||||||||
HOWE, John Martin | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | United Kingdom | British | National Service Director | 160895570001 | ||||||||
LARNDER, Amanda Louise | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Head Of Finance | 257818550001 | ||||||||
MOONAN, Paul Edmund | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | England | British | Director | 116051560001 | ||||||||
ORME, David Michael | Geschäftsführer | 42 Gatesbridge Park DN9 3NY Finningley South Yorkshire | British | Operations Director | 107352950001 | |||||||||
POTTER, Lester Gordon | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | England | British | Company Director | 160602240001 | ||||||||
POULTNEY, Nigel Charles | Geschäftsführer | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | England | British | Accountant | 8488600002 | ||||||||
ROBINSON, Glenn | Geschäftsführer | 15 Packhorse Road DE73 1EG Melbourne Derbyshire | England | British | Director | 184224940001 | ||||||||
SHEPHERD, John, Mr. | Geschäftsführer | Lower Farm St Margarets Road GL20 8NN Alderton Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 151588320001 | ||||||||
SINGLETON, Russell Craig | Geschäftsführer | 417 Whirlowdale Road S11 9NG Sheffield South Yorkshire | England | British | Managing Director | 3492940001 | ||||||||
STILWELL, Michael James | Geschäftsführer | Studley Point 88 Birmingham Road B80 7AS Studley C/O Synectics Plc Warwickshire | England | British | Finance Director | 194783340001 | ||||||||
STRINGER, Iain Phillip | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Director | 271740300001 | ||||||||
TOWN, Julie | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham | England | British | Accountant | 103458330001 | ||||||||
WEBB, Paul Anthony | Geschäftsführer | Attenborough Lane NG9 5JN Chilwell 3 Nottingham United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 156812260001 | ||||||||
FOTOVALUE LIMITED | Geschäftsführer | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom |
| 112770340001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OCULAR INTEGRATION LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synectics Plc | 06. Apr. 2016 | 3- 4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0