EVOLVE ENERGY LTD
Überblick
| Unternehmensname | EVOLVE ENERGY LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05831752 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EVOLVE ENERGY LTD?
- Elektroinstallation (43210) / Bauwesen
Wo befindet sich EVOLVE ENERGY LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVOLVE ENERGY LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EVOLVE ENERGY LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Ernennung von Nathan Sanders als Direktor am 03. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter Bradley als Direktor am 12. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Aled Robert Humphreys als Geschäftsführer am 12. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Brian Dominic Sharma als Sekretär am 18. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Archie Stuart Waddell als Sekretär am 18. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Dominic Sharma als Sekretär am 05. Juli 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Archie Stuart Waddell als Sekretär am 05. Juli 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Mcphillimy als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Brian Dominic Sharma als Sekretär am 11. Mai 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Veronica Mary Niven als Sekretär am 11. Mai 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Brinsley Sheridan als Geschäftsführer am 15. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Aled Robert Humphreys als Direktor am 12. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 21. März 2014 | 16 Seiten | RP04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EVOLVE ENERGY LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARMA, Brian Dominic | Sekretär | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 250773850001 | |||||||
| BRADLEY, Peter | Geschäftsführer | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Sse Enterprise Energy Solutions Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75211210001 | |||||
| GREENHORN, Kevin David Andrew | Geschäftsführer | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 145709970001 | |||||
| SANDERS, Nathan | Geschäftsführer | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | England | British | 150936520002 | |||||
| BUDD, Gerald Lance | Sekretär | Manston Road GU4 7YE Guildford 4 Surrey | British | 20717760001 | ||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Sekretär | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | 170751860001 | |||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Sekretär | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | 190141550001 | |||||||
| PARKE, Gary | Sekretär | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| SCHNEIDER, Tim | Sekretär | Citra Barn Frizers Farm Sonning Eye RG4 6TN Reading Berkshire | Canadian | 117731640001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Sekretär | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 208039170001 | |||||||
| TOPP, Janice Susan | Sekretär | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Other | 139112080001 | ||||||
| WADDELL, Archie Stuart | Sekretär | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 234996520001 | |||||||
| DUPORT SECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Southfield Road BS9 3BH Westbury On Trym The Bristol Office Bristol | 900020060001 | |||||||
| BAETZ, Michael | Geschäftsführer | 161 Bay Street, Suite 4540 PO BOX 709 M5J2S1 Toronto Canada Trust Tower Ontario Canada | Canada | Canadian | 166562600001 | |||||
| FRIGHT, Neil Grant | Geschäftsführer | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 165864840002 | |||||
| HIGGINS, Vanessa Claire | Geschäftsführer | Denchworth OX12 0DX Wantage Denchworth Manor Oxfordshire United Kingdom | England | British | 139427570001 | |||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Geschäftsführer | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | 17572470002 | |||||
| HUMPHREYS, Aled Robert | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 200150330001 | |||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Geschäftsführer | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | England | British | 18996670003 | |||||
| MCPHILLIMY, James | Geschäftsführer | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 94397700001 | |||||
| NIVEN, Veronica Mary | Geschäftsführer | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 173743440001 | |||||
| PARKE, Gary | Geschäftsführer | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| ROTHERHAM, David Scott | Geschäftsführer | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 146140260002 | |||||
| SCHNEIDER, Timothy John | Geschäftsführer | Wyatt Close Wargrave RG10 8EB Reading 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 150003200001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Geschäftsführer | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHLESINGER, Joseph Charles | Geschäftsführer | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 139607450001 | |||||
| SOPER, Daniel | Geschäftsführer | 20 Grey Road Toronto Ontario M5m 4ez Canada | Canadian | 117597800001 | ||||||
| STEVENSON, Lawrence Napier | Geschäftsführer | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 131305220002 | |||||
| TENNENT, Colin Robert | Geschäftsführer | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | England | British | 23661940005 | |||||
| DUPORT DIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Southfield Road Westbury-On-Trym BS9 3BH Bristol | 900020050001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EVOLVE ENERGY LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Energy Solutions Group Bidco Limited | 06. Apr. 2016 | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EVOLVE ENERGY LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 2012 Geliefert am 10. Nov. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Juli 2012 Geliefert am 15. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 21. Juli 2011 Geliefert am 29. Juli 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juni 2008 Geliefert am 24. Juni 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge | Erstellt am 30. Nov. 2006 Geliefert am 14. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £850,000.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Share capital in ashdown control services limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0