ABP ACQUISITIONS UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ABP ACQUISITIONS UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05839361 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 25 Bedford Street WC2E 9ES London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ADMIRAL ACQUISITIONS UK LIMITED | 07. Juni 2006 | 07. Juni 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Juni 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Juni 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Juni 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Eintragung der Belastung 058393610006, erstellt am 04. Sept. 2025 | 87 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 32 Seiten | AA | ||
Ernennung von Munroop Atwal als Direktor am 01. Okt. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Marina May Wyatt als Geschäftsführer am 01. Okt. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Henrik Lundgaard Pedersen am 01. Mai 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 128 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 40 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 42 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 40 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Henrik Lundgaard Pedersen am 24. Aug. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 42 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 38 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von George Sebastian Matthew Bull als Geschäftsführer am 29. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mrs Marina May Wyatt als Direktor am 14. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von George Philip Roger Kay als Geschäftsführer am 14. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Eric Philippe Marianne Machiels als Geschäftsführer am 14. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Hakim Drissi Kaitouni als Geschäftsführer am 14. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Dmitry Yashnikov als Geschäftsführer am 14. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Bedford Street WC2E 9ES London 25 |
| 199421600001 | ||||||||||
| ATWAL, Munroop | Geschäftsführer | Bedford Street WC2E 9ES London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 297808020001 | |||||||||
| KENNEDY, Shaun Richard | Geschäftsführer | Bedford Street WC2E 9ES London 25 United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 253444350001 | |||||||||
| PEDERSEN, Henrik Lundgaard | Geschäftsführer | Bedford Street WC2E 9ES London 25 United Kingdom | England | Danish | 249701480003 | |||||||||
| DIBBEN, Ann | Sekretär | 71-91 Aldwych WC2B 4HN London Aldwych House | British | 94474380003 | ||||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Sekretär | 71-91 Aldwych WC2B 4HN London Aldwych House United Kingdom | 188432240001 | |||||||||||
| RICHARDSON, Elaine | Sekretär | 71-91 Aldwych WC2B 4HN London Aldwych House | 183513510001 | |||||||||||
| SUTCLIFFE, Colleen Tracey | Sekretär | 293 Commonside East CR4 1HD Mitcham Surrey | British | 91707180003 | ||||||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol | 97584300001 | |||||||||||
| ANG, Eng Seng | Geschäftsführer | Belgrave House 76 Buckingham Palace Road SW1W 9TQ London | Singapore | 115549410002 | ||||||||||
| BLOEMEN, Peter-Paul Josef Marie | Geschäftsführer | Borealis Infrastructure Royal Blank Plaza, South Tower, 200 Bay Street M5J 2J2 Suite 2100 Vice President Toronto Canada | Canada | Canadian | 194049790001 | |||||||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London Borealis Infrastructure Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 203542960001 | |||||||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London Borealis Infrastructure Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 203542960001 | |||||||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Geschäftsführer | 71-91 Aldwych WC2B 4HN London Aldwych House | England | British | 147513860001 | |||||||||
| BULL, George Sebastian Matthew | Geschäftsführer | Bedford Street WC2E 9ES London 25 United Kingdom | England | British | 214260650001 | |||||||||
| BUSSLINGER, Philippe Anastase | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London Borealis Infrastructure Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Swiss | 155633860002 | |||||||||
| BUTCHER, Philip | Geschäftsführer | 40 Portman Square W1H 6LT London C/O Cppib England England | England | Canadian | 210529260001 | |||||||||
| CAMU, Philippe Louis Hubert | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Ltd 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International Ltd England | United Kingdom | Belgian | 116261790001 | |||||||||
| CLARKE, Edward Hilton | Geschäftsführer | Laurence Poutney Hill EC4R 0HH London Infracapital Llp England | United Kingdom | British | 89466210001 | |||||||||
| CLARKE, Edward Hilton | Geschäftsführer | 70 Waterford Road SW6 2DR London | United Kingdom | British | 89466210001 | |||||||||
| COOPER, James Nigel Shelley | Geschäftsführer | 71-91 Aldwych WC2B 4HN London Aldwych House | England | British | 265561970001 | |||||||||
| DHANANI, Jamal | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 108606760002 | ||||||||||
| DRISSI KAITOUNI, Hakim | Geschäftsführer | 15 Carter Lane EC4V 5EY London Wren House United Kingdom | United Kingdom | British | 199219690002 | |||||||||
| FERGUSON II, Thomas Dewitt | Geschäftsführer | Managing Director, Goldman Sachs International 100 Crescent Court, Suite 1000 TX 75201 Dallas Managing Director, Goldman Sachs International Usa | United States Citize | 116994740002 | ||||||||||
| HAY, Andrew | Geschäftsführer | 40 Portman Square W1H 6LT London C/O Cppib England England | Canada | Canadian | 210464760001 | |||||||||
| KAY, George Phillip Roger | Geschäftsführer | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London C/O Gic Special Investments Infrastructure Group | United Kingdom | British | 114120240010 | |||||||||
| KERR, David William | Geschäftsführer | Floor 1st Floor York House, 45 Seymour Street W1H 7LX London 1st | England | British | 149624450002 | |||||||||
| KNOWLTON, John | Geschäftsführer | 1174 Carey Road, Oakville Ontario L6j 2e4 Canada | Canadian | 115609640001 | ||||||||||
| LILLEY, Stephen Bernard | Geschäftsführer | Cypress Lodge Oak End Way SL9 8DB Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 115160890001 | |||||||||
| LYNEHAM, Peter Robert | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Ltd 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International Ltd England | England | Australian | 169897730001 | |||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Geschäftsführer | Bedford Street WC2E 9ES London 25 United Kingdom | England | Belgian | 125748990002 | |||||||||
| MCMANUS, John James | Geschäftsführer | Suite 2100, Box 56 M5J 2J2 Toronto Royal Bank Plaza, South Tower Canada | Canada | Canadian | 166238870004 | |||||||||
| NELSON, Stephen Keith James | Geschäftsführer | Laurence Poutney Hill EC4R 0HH London Infracapital Llp England | England | British | 180357720001 | |||||||||
| NOLAN, Philip Michael Gerard, Dr. | Geschäftsführer | Bedford Street WC2E 9ES London 25 England England | Ireland | British | 148563050001 | |||||||||
| PESTRAK, Gregory Stuart | Geschäftsführer | Bedford Street WC2E 9ES London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 242441320001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ABP ACQUISITIONS UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abpa Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Bedford Street WC2E 9ES London 25 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0