PROJECT CRESTA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePROJECT CRESTA LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05844617
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PROJECT CRESTA LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PROJECT CRESTA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PROJECT CRESTA LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NFT DISTRIBUTION HOLDINGS LIMITED06. Juli 200606. Juli 2006
    DE FACTO 1378 LIMITED13. Juni 200613. Juni 2006

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROJECT CRESTA LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für PROJECT CRESTA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Azalea Close, Clover Nook Industrial Park Somercotes Alfreton Derbyshire DE55 4QX zum One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH am 13. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Sept. 2016

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    18 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 28. Juli 2016

    • Kapital: GBP 1.116122
    SH01

    Erfüllung der Belastung 058446170002 vollständig

    4 SeitenMR04

    Kapitalaufstellung am 11. März 2016

    • Kapital: GBP 1.116120
    74 SeitenSH19

    legacy

    4 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Reduction of the share premium account to nil 24/02/2016
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 06. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 78,004.7369
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Azalea Close Clover Nook Industrial Estate Somercoates Alfreton Derbyshire DE55 4QX zum 1 Azalea Close, Clover Nook Industrial Park Somercotes Alfreton Derbyshire DE55 4QX am 06. Aug. 2015

    1 SeitenAD01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed nft distribution holdings LIMITED\certificate issued on 26/03/15
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 25. März 2015

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Ernennung von Mr Roger Moh als Direktor am 04. März 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Simon Pearson als Direktor am 04. März 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Mark Davis als Direktor am 04. März 2015

    2 SeitenAP01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    29 SeitenAA

    Ernennung von Mr Heath Zarin als Direktor am 24. Sept. 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    13 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 21. Juli 2014

    • Kapital: GBP 78,004.7369
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    13 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beschlüsse

    Resolutions
    13 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von PROJECT CRESTA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIS, Mark
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Sekretär
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    170641550001
    DAVIS, Mark
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Geschäftsführer
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    United KingdomBritish186608830001
    DENNISON, Steven Christopher
    Perkins Farm
    Perkinsway Newnham
    NN11 3EX Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Perkins Farm
    Perkinsway Newnham
    NN11 3EX Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish117228460001
    FRANKISH, David
    10 Weyacres
    Borrowash
    DE72 3QT Derby
    Geschäftsführer
    10 Weyacres
    Borrowash
    DE72 3QT Derby
    EnglandBritish18127330002
    MOH, Roger
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Geschäftsführer
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    SingaporeSingaporean195551610001
    PEARSON, Simon
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Geschäftsführer
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    ChinaBritish195551580001
    ZARIN, Heath
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Geschäftsführer
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Hong Kong SarAmerican191231280001
    DENNISON, Steven Christopher
    Perkins Farm
    Perkinsway Newnham
    NN11 3EX Daventry
    Northamptonshire
    Sekretär
    Perkins Farm
    Perkinsway Newnham
    NN11 3EX Daventry
    Northamptonshire
    British117228460001
    DUNN, Timothy Michael
    67 Gowan Avenue
    Fulham
    SW6 6RH London
    Sekretär
    67 Gowan Avenue
    Fulham
    SW6 6RH London
    British126838820001
    STEPHENS, Charles Robert
    5 Croft Way
    Everton
    DN10 5DL Doncaster
    South Yorkshire
    Sekretär
    5 Croft Way
    Everton
    DN10 5DL Doncaster
    South Yorkshire
    British115581920001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Sekretär
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001
    BROWN, Ernest Gerald Freeman
    Lily Rose 10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Lily Rose 10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    EnglandBritish60315730001
    DAW, Richard William
    144 Park Road
    Chiswick
    W4 3HP London
    Geschäftsführer
    144 Park Road
    Chiswick
    W4 3HP London
    EnglandBritish86615970002
    DUNN, Timothy Michael
    67 Gowan Avenue
    Fulham
    SW6 6RH London
    Geschäftsführer
    67 Gowan Avenue
    Fulham
    SW6 6RH London
    United KingdomBritish126838820003
    GRAHAM, James
    Azalea Close
    Clover Nook Industrial Estate
    DE55 4QX Somercoates Alfreton
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Azalea Close
    Clover Nook Industrial Estate
    DE55 4QX Somercoates Alfreton
    Derbyshire
    EnglandBritish188541610001
    STEPHENS, Charles Robert
    5 Croft Way
    Everton
    DN10 5DL Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Croft Way
    Everton
    DN10 5DL Doncaster
    South Yorkshire
    British115581920001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    47670880001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001

    Hat PROJECT CRESTA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 11. Apr. 2014
    Geliefert am 14. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Each chargor, as continuing security for the payment, discharge and performance of all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly or severally, as principal or as surety or in any capacity whatsoever) of each of the obligors to the bank on any account whatsoever and howsoever arising (including, without limitation, under the financing documents) together with all expenses in relation to all of the following assets whether now or in future belonging to that chargor hereby, in each case with full title guarantee charges to the bank by way of separate fixed charges:. (I) by way of legal mortgage each property specified in schedule 2 which is set opposite its name;. (Ii) by way of equitable mortgage all freehold and leasehold properties and other real property both present and future, including all buildings and other structures from time to time erected thereon and all fixtures (trade or otherwise) from time to time thereon or therein, other than the property or properties specified in schedule 2;. (iii) all its patents (including applications for and rights to apply for patents), trademarks and service marks (whether registered or not) and applications for the same, trade names, registered designs, design rights, semi-conductor topography rights, database rights, copyrights, computer programs, know-how and trade secrets and all other intellectual or intangible property or rights and all licences, agreements and ancillary and connected rights relating to intellectual and intangible property including any renewals, revivals or extensions thereof and wherever in the world subsisting.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 21. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group debenture
    Erstellt am 28. Juni 2012
    Geliefert am 04. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat PROJECT CRESTA LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juli 2017Aufgelöst am
    21. Sept. 2016Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0