PROJECT CRESTA LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PROJECT CRESTA LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05844617 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROJECT CRESTA LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PROJECT CRESTA LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PROJECT CRESTA LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NFT DISTRIBUTION HOLDINGS LIMITED | 06. Juli 2006 | 06. Juli 2006 |
| DE FACTO 1378 LIMITED | 13. Juni 2006 | 13. Juni 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROJECT CRESTA LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROJECT CRESTA LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Azalea Close, Clover Nook Industrial Park Somercotes Alfreton Derbyshire DE55 4QX zum One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH am 13. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 18 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 058446170002 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. März 2016
| 74 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Azalea Close Clover Nook Industrial Estate Somercoates Alfreton Derbyshire DE55 4QX zum 1 Azalea Close, Clover Nook Industrial Park Somercotes Alfreton Derbyshire DE55 4QX am 06. Aug. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed nft distribution holdings LIMITED\certificate issued on 26/03/15 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Roger Moh als Direktor am 04. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Pearson als Direktor am 04. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Davis als Direktor am 04. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 29 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Heath Zarin als Direktor am 24. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 13 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROJECT CRESTA LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIS, Mark | Sekretär | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | 170641550001 | |||||||
| DAVIS, Mark | Geschäftsführer | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | United Kingdom | British | 186608830001 | |||||
| DENNISON, Steven Christopher | Geschäftsführer | Perkins Farm Perkinsway Newnham NN11 3EX Daventry Northamptonshire | England | British | 117228460001 | |||||
| FRANKISH, David | Geschäftsführer | 10 Weyacres Borrowash DE72 3QT Derby | England | British | 18127330002 | |||||
| MOH, Roger | Geschäftsführer | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | Singapore | Singaporean | 195551610001 | |||||
| PEARSON, Simon | Geschäftsführer | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | China | British | 195551580001 | |||||
| ZARIN, Heath | Geschäftsführer | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | Hong Kong Sar | American | 191231280001 | |||||
| DENNISON, Steven Christopher | Sekretär | Perkins Farm Perkinsway Newnham NN11 3EX Daventry Northamptonshire | British | 117228460001 | ||||||
| DUNN, Timothy Michael | Sekretär | 67 Gowan Avenue Fulham SW6 6RH London | British | 126838820001 | ||||||
| STEPHENS, Charles Robert | Sekretär | 5 Croft Way Everton DN10 5DL Doncaster South Yorkshire | British | 115581920001 | ||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 38590450001 | |||||||
| BROWN, Ernest Gerald Freeman | Geschäftsführer | Lily Rose 10 Elsley Road Tilehurst RG31 6RN Reading Berkshire | England | British | 60315730001 | |||||
| DAW, Richard William | Geschäftsführer | 144 Park Road Chiswick W4 3HP London | England | British | 86615970002 | |||||
| DUNN, Timothy Michael | Geschäftsführer | 67 Gowan Avenue Fulham SW6 6RH London | United Kingdom | British | 126838820003 | |||||
| GRAHAM, James | Geschäftsführer | Azalea Close Clover Nook Industrial Estate DE55 4QX Somercoates Alfreton Derbyshire | England | British | 188541610001 | |||||
| STEPHENS, Charles Robert | Geschäftsführer | 5 Croft Way Everton DN10 5DL Doncaster South Yorkshire | British | 115581920001 | ||||||
| TRAVERS SMITH LIMITED | Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 47670880001 | |||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 38590450001 |
Hat PROJECT CRESTA LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 11. Apr. 2014 Geliefert am 14. Apr. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Each chargor, as continuing security for the payment, discharge and performance of all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly or severally, as principal or as surety or in any capacity whatsoever) of each of the obligors to the bank on any account whatsoever and howsoever arising (including, without limitation, under the financing documents) together with all expenses in relation to all of the following assets whether now or in future belonging to that chargor hereby, in each case with full title guarantee charges to the bank by way of separate fixed charges:. (I) by way of legal mortgage each property specified in schedule 2 which is set opposite its name;. (Ii) by way of equitable mortgage all freehold and leasehold properties and other real property both present and future, including all buildings and other structures from time to time erected thereon and all fixtures (trade or otherwise) from time to time thereon or therein, other than the property or properties specified in schedule 2;. (iii) all its patents (including applications for and rights to apply for patents), trademarks and service marks (whether registered or not) and applications for the same, trade names, registered designs, design rights, semi-conductor topography rights, database rights, copyrights, computer programs, know-how and trade secrets and all other intellectual or intangible property or rights and all licences, agreements and ancillary and connected rights relating to intellectual and intangible property including any renewals, revivals or extensions thereof and wherever in the world subsisting. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 28. Juni 2012 Geliefert am 04. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PROJECT CRESTA LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0