KAYE ENGINEERING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKAYE ENGINEERING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05848144
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KAYE ENGINEERING LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich KAYE ENGINEERING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KAYE ENGINEERING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für KAYE ENGINEERING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2019

    17 SeitenLIQ03

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER zum Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW am 07. Juni 2019

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2018

    22 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2017

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2016

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2015

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2014

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2013

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Juli 2012

    14 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Juli 2011

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    22 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Jan. 2011

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    legacy

    3 SeitenMG02

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Juli 2010

    16 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    15 Seiten2.16B

    Beendigung der Bestellung von Paul Davidson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    26 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    17 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    29 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Mta Corporate Solicitors Llp 5 Breams Buildings London EC4A 1DY* am 06. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von KAYE ENGINEERING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAILEY, John Christopher Leeksma
    Crane Grove
    N7 8LD London
    23
    Sekretär
    Crane Grove
    N7 8LD London
    23
    British18758630003
    NEAGLE, Peter James
    Swainswood
    Northend
    RG9 6LF Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Swainswood
    Northend
    RG9 6LF Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomEnglishDirector19756180001
    SMITH, Geoffrey Thurstan
    27 Hillview Lane
    Twyning
    GL20 6JW Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    27 Hillview Lane
    Twyning
    GL20 6JW Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglishChartered Accountant18722440001
    BAILEY, John Christopher Leeksma
    Crane Grove
    N7 8LD London
    23
    Sekretär
    Crane Grove
    N7 8LD London
    23
    British18758630003
    BRADLEY HOARE, Jonathan
    9 Drewsteignton
    SS3 8BA Shoeburyness
    Essex
    Sekretär
    9 Drewsteignton
    SS3 8BA Shoeburyness
    Essex
    BritishAccountant99887640001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    Bevollmächtigter Sekretär
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    DAVIDSON, Paul Arthur
    Border House
    Ford Street Stapleton
    LD8 2LN Presteigne
    Powys
    Geschäftsführer
    Border House
    Ford Street Stapleton
    LD8 2LN Presteigne
    Powys
    BritishEngineer126957280001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001

    Hat KAYE ENGINEERING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 03. Juli 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental chattel mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 2008
    Geliefert am 04. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Walther trowal shot blaster no thm 500/2/e through fee continuous shot blast c/w bath loader U18RO food station in feed elevator out feed conveyor extraction and controls 10250018 2002 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juni 2008
    Geliefert am 19. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merchant Trade Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental chattel mortgage
    Erstellt am 12. Sept. 2006
    Geliefert am 21. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Striko type MH2-N1000/1000 g-eg 2 x 1 tonne gas fired furnaces (1995) with siemens coros OP1S controls and chargers ser no 150100795, striko type MH2-N100011000 g-eg 2 x 1 tonne gas fired furnaces with siemens coros OP15 controls and chargers ser no 150050395 and r & j williams de-gassing unit ser no 298564/1 for details of further property charged please refer to form 395 together with the benefit of all existing guarantees warranties and servicing and maintenance agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Sept. 2006
    Geliefert am 15. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. Sept. 2006
    Geliefert am 18. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all of the rights in land, equipment, investments, intellectual property and debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J L French UK Limited (In Administration)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Aug. 2006
    Geliefert am 22. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arbuthnot Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat KAYE ENGINEERING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Jan. 2010Beginn der Verwaltung
    12. Juli 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    2
    DatumTyp
    01. Aug. 2020Aufgelöst am
    12. Juli 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0