TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05888960 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tesco House, Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 26. Feb. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Feb. 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Simon Richard Williams als Direktor am 25. Feb. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Gibney als Geschäftsführer am 25. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Feb. 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Feb. 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Gibney am 02. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr. Alistair Ewan Clark am 01. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Feb. 2018 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 182118090001 | ||||||||||
CLARK, Alistair Ewan, Mr. | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Treasurer | 160520990004 | ||||||||
WILLIAMS, Simon Richard | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | England | British | Acquisition Director | 293302020001 | ||||||||
EKPO, Ndiana | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
O'CONNOR, Claudine Elaine | Sekretär | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | Assistant Company Secretary | 50295880003 | |||||||||
PHILP, Clive James | Sekretär | Oakey Lane SE1 7HN London 25 United Kingdom | British | 140785910001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Sekretär | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
PAILEX SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 20 Bedford Row WC1R 4JS London | 74551790001 | |||||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Geschäftsführer | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRASHER, Richard William Peter | Geschäftsführer | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 70633600002 | ||||||||
EADE, Graham Peter | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | New Zealand | Director | 153426190001 | ||||||||
EARP, Neil Timothy | Geschäftsführer | Tesco Plc Tesco House, Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Herts. | British | Company Director | 83045240002 | |||||||||
GIBNEY, John | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | United Kingdom | Irish | Assets And Estates Director | 194216530003 | ||||||||
HARTLEY, Johanna Ruth | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 168410960001 | ||||||||
HARTLEY, Johanna Ruth | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 168410960001 | ||||||||
LEWIS, Bryan John | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 58257940003 | ||||||||
LU, Hongyan Echo | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Chinese | Uk & Roi Property Director | 171720380001 | ||||||||
MAIR, Ian | Geschäftsführer | Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Tesco House Herts. United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Treasurer | 156335170001 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
MOURANT, Nicholas Claud | Geschäftsführer | Tesco House Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 67463160002 | ||||||||
O'HARE, Eamonn | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | Director | 117596190001 | |||||||||
POTTS, David Thomas | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 61624730005 | ||||||||
RENNIE, James Matthew | Geschäftsführer | 23 Queens Road HP4 3HU Berkhamstead Hertfordshire | British | Chartered Surveyor | 99037070001 | |||||||||
RIGBY, Steven Andrew | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Waltham Cross | United Kingdom | British | Surveyor | 161159630001 | ||||||||
RISK, Michael Robert | Geschäftsführer | Highcroft Kelshall Street SG8 9SH Kelshall Hertfordshire | England | British | Director | 70209830002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Geschäftsführer | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
STIRLING, Mark Andrew | Geschäftsführer | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | England | British | Surveyor | 106882210001 | ||||||||
WHITE, Emily | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 149676640001 | ||||||||
WITHAM, Mark Peter | Geschäftsführer | Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Tesco House Hertfordshire | British | Surveyor | 128610500001 | |||||||||
PAILEX NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 20 Bedford Row WC1R 4JS London | 74551780001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesco Aqua (Nominee Holdco) Limited | 06. Apr. 2016 | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TESCO AQUA (NOMINEE 2) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 11. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest under the head lease being the tesco store at nairn road forres t/n MOR6760. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignation of rental income dated 19TH march and creation | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 05. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnership, the nominees, nominees holdco, the general partner to each, some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of amendment | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The partnership secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Allerton road store mather avenue allerton liverpool, ashford middlesex store town lane stanwell staines middlesex and dinnington store undergate road dinnington south yorkshire for details of further property charged please refer to form 3. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental nominees deed of charge | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 27. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnership, the nominees, nominees holdco, the general partner to each, some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Mather avenue allerton liverpool t/no MS531364, town lane stanwell staines middlesex t/no SYK57772, undergate road dinnington south yorkshire and the land t/NOSYK528770 (for details of further proper. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 26/03/2007 and | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 12. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Tenants interest in head lease of tesco store at riverside drive dundee t/no ang 45238. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 26/03/2007 and | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 12. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Tenants interest in head lease of tesco store at western road montrose t/no ang 45239. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 11. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest under the head lease being the tesco store at kingsway west, dundee t/n ANG45174. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 11. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a tesco sto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 11. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole subjects k/a tesco store western road montrose tayside t/no ANG45239. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 11. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole subjects k/a tesco store kingsway west dundee county of angus t/no ANG45174. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2007 and | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 11. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnership the nominees nominees holdco and the general partner to each some or any of the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the tenants interest in the head lease relating to the subjects k/a tesco store riverside drive dundee tayside t/no ANG45238. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Nominees deed of charge | Erstellt am 09. Okt. 2006 Geliefert am 24. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the partnership secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Branch no 2022 allerton road mather avenue allerton liverpool,2047 ashford middlesex town lane stanwell staines middlesex,5105 dinnington undergate road dinnington south yorkshire (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0