EXTRABONUS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEXTRABONUS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05890070
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EXTRABONUS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich EXTRABONUS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Gable House
    239 Regents Park Road
    N3 3LF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXTRABONUS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis09. Nov. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für EXTRABONUS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 19-20 Bourne Court Southend Road Woodford Green Essex IG8 8HD United Kingdom zum Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF am 22. Nov. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Nov. 2016

    LRESSP

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 09. Nov. 2016

    6 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2017 bis 09. Nov. 2016

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2016

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Adams am 15. Feb. 2016

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 19-20 Bourne Court Southend Road Woodford Green Essex IG8 8HD zum 19-20 Bourne Court Southend Road Woodford Green Essex IG8 8HD am 22. Aug. 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Juli 2015

    • Kapital: GBP 1.4357
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 14. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1.4357
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF England zum 19-20 Bourne Court Southend Road Woodford Green Essex IG8 8HD am 08. Dez. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2014

    6 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Adams am 20. Juli 2014

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 59-60 Grosvenor Street Mayfair London W1K 3HZ England zum Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF am 26. Sept. 2014

    1 SeitenAD01

    Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft

    1 SeitenDS02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Mark Adams als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Rust als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von EXTRABONUS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ADAMS, Mark
    Southend Road
    IG8 8HD Woodford Green
    19-20 Bourne Court
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Southend Road
    IG8 8HD Woodford Green
    19-20 Bourne Court
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector128037810001
    GREVILLE, Helen Mary
    141 Dawpool Road
    Cricklewood
    NW2 7LA London
    Sekretär
    141 Dawpool Road
    Cricklewood
    NW2 7LA London
    British110788860001
    RAYMOND, Louise Charlotte
    11 Freelands Grove
    BR1 3LH Bromley
    Kent
    Sekretär
    11 Freelands Grove
    BR1 3LH Bromley
    Kent
    BritishSales & Marketing124463060001
    RUST, Jonathan Simon David Anthony
    The Uplands
    AL5 2PQ Harpenden
    26
    Hertfordshire
    England
    Sekretär
    The Uplands
    AL5 2PQ Harpenden
    26
    Hertfordshire
    England
    BritishCompany Secretary91991430001
    VINER, Paul Lewis
    Deansway
    N2 0JF London
    24
    United Kingdom
    Sekretär
    Deansway
    N2 0JF London
    24
    United Kingdom
    British117768960004
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    PALOS, Brett Alexander
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    Geschäftsführer
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United KingdomBritishNone151119360001
    RITCHIE, Bruce Weir
    Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60
    England
    Geschäftsführer
    Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60
    England
    EnglandBritishDirector61895720004
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EXTRABONUS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Prime London Residential Limited
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60 Grosvenor Street
    England
    06. Apr. 2016
    Mayfair
    W1K 3HZ London
    59-60 Grosvenor Street
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer07181606
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat EXTRABONUS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 01. Apr. 2011
    Geliefert am 05. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 20. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 10. Mai 2010
    Geliefert am 19. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Luke house t/n NGL763663, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 19. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Accession deed
    Erstellt am 13. Sept. 2007
    Geliefert am 22. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other fund 1 security beneficiaries (or any of them) and from the company to the chargee and/or the other fund 2 security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2007
    Geliefert am 22. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Flat 82 forest court 140 edgware road london t/n NGL883716 all buildings erections fittings and fixtures all easements rights proceeds of sale benefit of all covenants.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Securitybeneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2007
    Geliefert am 27. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Apr. 2007
    Geliefert am 18. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H flat 82 forset court edgeware road london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EXTRABONUS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2016Beginn der Liquidation
    16. Aug. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stella Davis
    Gable House
    239 Regents Park Road
    N3 3LF London
    Praktiker
    Gable House
    239 Regents Park Road
    N3 3LF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0