GRS PUB INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GRS PUB INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05895613 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INN INVESTMENT LIMITED | 16. Okt. 2006 | 16. Okt. 2006 |
| MISLEX (504) LIMITED | 03. Aug. 2006 | 03. Aug. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 18 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Keith Finlay Thomson als Geschäftsführer am 01. Apr. 2018 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Samual Edward Kennedy als Geschäftsführer am 01. Apr. 2018 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Aug. 2017 | 32 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 31 Haverscroft Industrial Estate New Road Attleborough Norfolk NR17 1YE zum Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL am 14. Sept. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2014 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 13 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2013 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2012 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Dez. 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2010 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2010 | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Dez. 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alastair Ferguson als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Russell Cawtheray als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Robinson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Buchanan als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSON, Alastair William | Sekretär | Haverscroft Industrial Estate New Road NR17 1YE Attleborough 31 Norfolk | British | 146760250001 | ||||||
| LELLO, Graham | Sekretär | 91a Haverhill Road Balham SW12 0HE London | South African | 97505870001 | ||||||
| THORNTON, Howard | Sekretär | 3 Kestrel Court Reedham NR13 3UH Norwich Norfolk | British | 149837760001 | ||||||
| WESTLEX REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Summit House 12 Red Lion Square WC1R 4QD London | 900030650001 | |||||||
| BUCHANAN, William Arthur Neil | Geschäftsführer | 3 Westerton Court Clarkston G76 8NG Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 67066450003 | |||||
| CAWTHERAY, Russell | Geschäftsführer | 8 Shears Crescent CO5 8AR West Mersea Essex | British | 124176180001 | ||||||
| CROWTHER, Mark | Geschäftsführer | Randwick House 5 Bridge Street NN14 3ET Brigstock Northamptonshire | British | 104967480001 | ||||||
| GUNDRY, Richard | Geschäftsführer | Holgate Farm 29 The Street Bunwell NR16 1NA Norwich Norfolk | British | 107010490001 | ||||||
| KENNEDY, Samual Edward | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square West Yorkshire | England | British | 149343140001 | |||||
| ROBINSON, Ian George | Geschäftsführer | 74 Brookmans Avenue Brookmans Park AL9 7QQ Hatfield Hertfordshire | England | British | 57975730001 | |||||
| THOMSON, Robert Keith Finlay | Geschäftsführer | 92 Tebworth Road LU7 9QH Wingfield Hill Copse | United Kingdom | British | 51167890002 | |||||
| THORNTON, Howard | Geschäftsführer | 3 Kestrel Court Reedham NR13 3UH Norwich Norfolk | England | British | 149837760001 | |||||
| WILSON, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 5 Court Lane Gardens Dulwich SE21 7DZ London | United Kingdom | British | 82667700001 | |||||
| WESTLEX NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Summit House 12 Red Lion Square WC1R 4QD London | 111785270001 |
Hat GRS PUB INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal charge | Erstellt am 11. Aug. 2009 Geliefert am 20. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its right title and interest in and to the legally mortgaged property wheatsheaf inn church road tattingstone ipswich t/n SK95910. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 03. Sept. 2007 Geliefert am 18. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or ny of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a mermaid delamore road handforth wilmslow t/no CH424877. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over shares | Erstellt am 13. Apr. 2007 Geliefert am 30. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed legal charge all of its present and future rights,title and interest in and to the scheduled securities. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 13. Apr. 2007 Geliefert am 30. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H angel west yorkshire t/no WYK520493,f/h barristers west yorkshire t/no WYK501088,f/h bridge tavern hampshire t/no HP543335 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 29. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Bird in hand main road westhay glastonbury f/h t/n ST163193. The fox inn fox lane souldern bicester f/h t/n ON248144. New harp inn hoarwithy hereford t/h t/n HW171880. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 28. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H albert hotel 75 buxton road disley stockport t/no CH359630,f/h alma george street newcastle under lyme t/no SF407098,f/h anchor inn burton road streethay lichfield staffs t/no SF344977 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income created 5TH january 2007 and | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 10. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The right title and interest present and future in and to the rent and all other monies. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income created 5TH january 2007 and | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 10. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The right title and interest present and future in and to the rent and all other monies. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 22 december 2006 and | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 05. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The inn, 18 shawton road, chapelton, strathaven. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 22 december 2006 and | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 05. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The swan inn, 62 lochinvar road cumbernauld. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Nov. 2006 Geliefert am 06. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Anchor inn fore street chudleigh knighton f/h t/n DN318739 bell inn 180 drew street brixham f/h t/n DN313236 cheddar valley inn tusker street wells f/h t/n ST89453. For further details of property charged please refer to form 395. the security assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GRS PUB INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0