GRS PUB INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGRS PUB INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05895613
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INN INVESTMENT LIMITED16. Okt. 200616. Okt. 2006
    MISLEX (504) LIMITED03. Aug. 200603. Aug. 2006

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Beendigung der Bestellung von Robert Keith Finlay Thomson als Geschäftsführer am 01. Apr. 2018

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Samual Edward Kennedy als Geschäftsführer am 01. Apr. 2018

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Aug. 2017

    32 SeitenLIQ03

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 31 Haverscroft Industrial Estate New Road Attleborough Norfolk NR17 1YE zum Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL am 14. Sept. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 11. Aug. 2016

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 13. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 13,889,684
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2014

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    13 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 03. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 8,405,766
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2013

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 8,405,766
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2012

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Dez. 2011

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2010

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2010

    14 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Dez. 2009

    16 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Alastair Ferguson als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Russell Cawtheray als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ian Robinson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von William Buchanan als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von GRS PUB INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FERGUSON, Alastair William
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Sekretär
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    British146760250001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Sekretär
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South African97505870001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    British149837760001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    Summit House 12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Summit House 12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    900030650001
    BUCHANAN, William Arthur Neil
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish67066450003
    CAWTHERAY, Russell
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    Geschäftsführer
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    British124176180001
    CROWTHER, Mark
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    British104967480001
    GUNDRY, Richard
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    British107010490001
    KENNEDY, Samual Edward
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    West Yorkshire
    EnglandBritish149343140001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish57975730001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse
    Geschäftsführer
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse
    United KingdomBritish51167890002
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish149837760001
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Geschäftsführer
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritish82667700001
    WESTLEX NOMINEES LIMITED
    Summit House
    12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    Geschäftsführer
    Summit House
    12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    111785270001

    Hat GRS PUB INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 11. Aug. 2009
    Geliefert am 20. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its right title and interest in and to the legally mortgaged property wheatsheaf inn church road tattingstone ipswich t/n SK95910.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2007
    Geliefert am 18. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or ny of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a mermaid delamore road handforth wilmslow t/no CH424877. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC, Acting Through Its London Branch as Security Agent for Itselfand the Other Finance Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over shares
    Erstellt am 13. Apr. 2007
    Geliefert am 30. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed legal charge all of its present and future rights,title and interest in and to the scheduled securities. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 13. Apr. 2007
    Geliefert am 30. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H angel west yorkshire t/no WYK520493,f/h barristers west yorkshire t/no WYK501088,f/h bridge tavern hampshire t/no HP543335 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 19. März 2007
    Geliefert am 29. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Bird in hand main road westhay glastonbury f/h t/n ST163193. The fox inn fox lane souldern bicester f/h t/n ON248144. New harp inn hoarwithy hereford t/h t/n HW171880. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent for Itself and the Other Finance Parties
    Transaktionen
    • 29. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 28. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H albert hotel 75 buxton road disley stockport t/no CH359630,f/h alma george street newcastle under lyme t/no SF407098,f/h anchor inn burton road streethay lichfield staffs t/no SF344977 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rental income created 5TH january 2007 and
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 10. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title and interest present and future in and to the rent and all other monies.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rental income created 5TH january 2007 and
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 10. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title and interest present and future in and to the rent and all other monies.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 22 december 2006 and
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The inn, 18 shawton road, chapelton, strathaven.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 22 december 2006 and
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The swan inn, 62 lochinvar road cumbernauld.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Nov. 2006
    Geliefert am 06. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Anchor inn fore street chudleigh knighton f/h t/n DN318739 bell inn 180 drew street brixham f/h t/n DN313236 cheddar valley inn tusker street wells f/h t/n ST89453. For further details of property charged please refer to form 395. the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GRS PUB INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Sept. 2018Aufgelöst am
    11. Aug. 2016Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Christian Chubb
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Lyn L Vardy
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praktiker
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0