WBHBE NO.2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WBHBE NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05895658 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WBHBE NO.2 LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich WBHBE NO.2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Finsgate 5-7 Cranwood Street EC1V 9EE London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WBHBE NO.2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BUSINESS ENVIRONMENT WESTBOURNE HOUSE LIMITED | 09. Nov. 2006 | 09. Nov. 2006 |
| MISLEX (508) LIMITED | 03. Aug. 2006 | 03. Aug. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WBHBE NO.2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WBHBE NO.2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 4 Seiten | AA | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 4 Seiten | AA | ||
Change of details for Wbhbe No. 1 Limited as a person with significant control on 22. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom zum Finsgate 5-7 Cranwood Street London EC1V 9EE am 16. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Haysmacintyre Company Secretaries Limited als Sekretär am 21. Mai 2019 | 2 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Wbhbe No. 1 Limited as a person with significant control on 18. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Haysmacintyre Company Secretaries Limited am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom zum 10 Queen Street Place London EC4R 1AG am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Haysmacintyre Company Secretaries Limited am 13. Nov. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 11 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 150 Minories London EC3N 1LS zum Central Point 45 Beech Street London EC2Y 8AD geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 07. Aug. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 14 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Michael Rusk als Sekretär am 16. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WBHBE NO.2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERT, Melvyn Stephen, Mr | Geschäftsführer | 45 Beech Street EC2Y 8AD London Central Point United Kingdom | United Kingdom | British | 6395630003 | |||||||||
| RUSK, Simon Michael, Mr. | Sekretär | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | British | 123853770003 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| WESTLEX REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Summit House 12 Red Lion Square WC1R 4QD London | 900030650001 | |||||||||||
| EMDEN, Andrew Marc | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 126685040002 | |||||||||
| GANDY, Nicolas Sean | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 135709440001 | |||||||||
| GERSHINSON, Colin Anthony | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 21890030001 | |||||||||
| HEFFERMAN, Graham Anthony | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | England | British | 77838960004 | |||||||||
| HODGES, Edwin Charles | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 83077420001 | |||||||||
| JENKINS, Jayson | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 126305070001 | |||||||||
| KLUG, Bernard Philip | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | England | British | 15387060004 | |||||||||
| MERCER, Graham Paul | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | England | British | 108922930002 | |||||||||
| RUSK, Simon Michael, Mr. | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 123853770003 | |||||||||
| SAUL, David Gary | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 57597480002 | |||||||||
| STEWART, Andrew Lawrence | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 23329410002 | |||||||||
| WESTLEX NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Summit House 12 Red Lion Square WC1R 4QD London | 111785270001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WBHBE NO.2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wbhbe No. 1 Limited | 06. Apr. 2016 | 5-7 Cranwood Street EC1V 9EE London Finsgate England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WBHBE NO.2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 06. Okt. 2008 Geliefert am 10. Okt. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Its credit balances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 13. März 2008 Geliefert am 15. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of a bank account specified in the agreement with the bank in the name of the company held at the banks city office branch. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 10. Dez. 2007 Geliefert am 12. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Jan. 2007 Geliefert am 25. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any f/h or l/h or other immovable property together with all buidings,trade and other fixtures,fixed plant and machienry,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 05. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first floating charge al the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a westbourne house, 14 and 16 westbourne grove, london t/no NGL812476 all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| General security assignment | Erstellt am 05. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of its right, title and interest in and to the contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0