SENTRUM SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSENTRUM SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05922736
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SENTRUM SERVICES LIMITED?

    • Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich SENTRUM SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Level 7 40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SENTRUM SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für SENTRUM SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU United Kingdom zum 35 Great St Helen's London EC3A 6AP geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Direktors für Ms Jeannie Lee am 20. Jan. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Intertrust (Uk) Limited am 20. Jan. 2017

    1 SeitenCH04

    Ernennung von Mr Robert Andrew Coupland als Direktor am 23. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Glennane als Geschäftsführer am 23. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    20 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für David Glennane am 11. Juli 2012

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Ms Jeannie Lee als Direktor am 29. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Joshua Ananda Mills als Geschäftsführer am 29. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Bernard Geoghegan als Geschäftsführer am 05. Nov. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    26 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU zum Level 7 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT am 19. Dez. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 29. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Intertrust (Uk) Limited als Sekretär

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Intertrust Holdings (Uk) Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    18 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SENTRUM SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    United Kingdom
    Sekretär
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer06307550
    188126550001
    COUPLAND, Robert Andrew
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    Level 7
    Geschäftsführer
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    Level 7
    United KingdomBritish138313750002
    LEE, Jeannie
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    Level 7
    Geschäftsführer
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    Level 7
    United StatesAmerican205746800001
    BRIDGE HOUSE SECRETARIES LIMITED
    Linen Hall
    162-168 Regent Street
    W1B 5TE London
    Suite 426
    Sekretär
    Linen Hall
    162-168 Regent Street
    W1B 5TE London
    Suite 426
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04816216
    97662290009
    INTERTRUST CORPORATE SERVICES (DUBLIN) LIMITED
    17/19 Sir John Rogerson's Quay
    Dublin 2
    The Anchorage
    Ireland
    Sekretär
    17/19 Sir John Rogerson's Quay
    Dublin 2
    The Anchorage
    Ireland
    RechtsformIRELAND
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageIRELAND
    Registrierungsnummer485527
    170635850002
    INTERTRUST HOLDINGS (UK) LIMITED
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    Sekretär
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer06263011
    126631680006
    GEOGHEGAN, Bernard
    Enniskerry
    48 Eagle Valley
    Wicklow
    Ireland (Republic Of)
    Geschäftsführer
    Enniskerry
    48 Eagle Valley
    Wicklow
    Ireland (Republic Of)
    IrelandIrish179097930001
    GLENNANE, David
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    Level 7
    Geschäftsführer
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    Level 7
    Republic Of IrelandIrish170639100001
    MCNALLY, Simon John
    Sulby Glen
    IM7 2AZ Sulby
    Glen Moar House
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Sulby Glen
    IM7 2AZ Sulby
    Glen Moar House
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish65751480002
    MCNALLY, Simon John
    Glenmoar House
    Sulby Glen, Sulby
    IM7 2AZ Ramsey
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Glenmoar House
    Sulby Glen, Sulby
    IM7 2AZ Ramsey
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish65751480002
    MCNALLY, Simon John
    Glenmoar House
    Sulby Glen, Sulby
    IM7 2AZ Ramsey
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Glenmoar House
    Sulby Glen, Sulby
    IM7 2AZ Ramsey
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish65751480002
    MILLS, Joshua Ananda
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    Uk
    England
    Geschäftsführer
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    Uk
    England
    UsaAmerican123070620001
    RUHAN, Andrew Joseph
    High Trees
    Shire Lane Horn Hill
    SL9 0QY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    High Trees
    Shire Lane Horn Hill
    SL9 0QY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish154690700001
    SCOTT, Stephen Derrick
    Wood Vale
    Forest Hill
    SE23 3DT London
    65
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wood Vale
    Forest Hill
    SE23 3DT London
    65
    United Kingdom
    United KingdomBritish222396530001
    SODZAWICZNY, Franek Jan
    Woodbury Farm
    Bank Lane
    WR6 6LR Little Witley
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Woodbury Farm
    Bank Lane
    WR6 6LR Little Witley
    Worcestershire
    EnglandBritish146533810001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SENTRUM SERVICES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Digital Realty Trust, Inc
    St Paul Street
    Suite 820
    21202 Baltimore
    7
    Maryland
    Usa
    06. Apr. 2016
    St Paul Street
    Suite 820
    21202 Baltimore
    7
    Maryland
    Usa
    Nein
    RechtsformCorporation
    RegistrierungslandMaryland
    RechtsgrundlageMaryland
    RegistrierungsortDepartment Of Assessment And Taxation
    RegistrierungsnummerDo7840788
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat SENTRUM SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2011
    Geliefert am 21. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 02. Juni 2011
    Geliefert am 04. Juni 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant's interest in all monies standing to the credit of the account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bdo LLP
    Transaktionen
    • 04. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 03. März 2010
    Geliefert am 04. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed
    Erstellt am 15. Apr. 2009
    Geliefert am 24. Apr. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional charged contracts, the contract proceeds and the insurance proceeds derived from the additional charged contracts. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2009
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Amended and restated debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 04. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of charge over account balances
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 26. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights, title and interest in and to the account balances by way of first fixed charge and by way of first floating charge see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment and charge of contracts relating to services agreements
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 26. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights, title and interest in the charged contracts, the contract proceeds and the insurance proceeds, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and variation
    Erstellt am 16. Mai 2008
    Geliefert am 03. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (and each qatar 2 obligor to the chargee) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The parties amend and restate the watford facility agreement and the woking facility agreement and to vary the watford security documents and the woking security documents in the manner set out in schedules 3 and 4, 5, 6 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 03. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental assignment
    Erstellt am 11. Apr. 2008
    Geliefert am 16. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sentrum limited to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its interest in each new assigned agreement, being a services agreement dated 10 april 2008 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC, in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fourth deed of variation
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 13. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the watford property, all shares of ssl and sl and the shares of shl. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third deed of variation
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 12. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the watford property, all shares of ssl and sl and the shares of shl. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third deed of variation
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 12. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the croydon property, all shares of ssl and sl and the shares of shl. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Second deed of variation
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 09. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All obligations and credit facilities of £59,750,000 to sl; fixed charge over the croydon property, all shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Second deed of variation
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 09. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All obligations and credit facilities of £59,750,000 to sl; fixed charge over the croydon property, all shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 18. Dez. 2007
    Geliefert am 21. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in each assigned agreement and all assigned income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 14. März 2007
    Geliefert am 03. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture (variation)
    Erstellt am 14. März 2007
    Geliefert am 04. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By the original debenture the chargors granted security (including a fixed charge over the croydon data centre) in favour of investec. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 08. Jan. 2007
    Geliefert am 25. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property at unit b prologis park beddington lane croydon surrey t/n SGL6. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0