SENTRUM SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SENTRUM SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05922736 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SENTRUM SERVICES LIMITED?
- Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SENTRUM SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Level 7 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SENTRUM SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SENTRUM SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU United Kingdom zum 35 Great St Helen's London EC3A 6AP geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Jeannie Lee am 20. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Intertrust (Uk) Limited am 20. Jan. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Andrew Coupland als Direktor am 23. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Glennane als Geschäftsführer am 23. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Glennane am 11. Juli 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Jeannie Lee als Direktor am 29. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joshua Ananda Mills als Geschäftsführer am 29. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bernard Geoghegan als Geschäftsführer am 05. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU zum Level 7 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT am 19. Dez. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Intertrust (Uk) Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Intertrust Holdings (Uk) Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SENTRUM SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Sekretär | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 United Kingdom |
| 188126550001 | ||||||||||||||
| COUPLAND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London Level 7 | United Kingdom | British | 138313750002 | |||||||||||||
| LEE, Jeannie | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London Level 7 | United States | American | 205746800001 | |||||||||||||
| BRIDGE HOUSE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Linen Hall 162-168 Regent Street W1B 5TE London Suite 426 |
| 97662290009 | ||||||||||||||
| INTERTRUST CORPORATE SERVICES (DUBLIN) LIMITED | Sekretär | 17/19 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 The Anchorage Ireland |
| 170635850002 | ||||||||||||||
| INTERTRUST HOLDINGS (UK) LIMITED | Sekretär | Old Jewry 7th Floor EC2R 8DU London 11 England |
| 126631680006 | ||||||||||||||
| GEOGHEGAN, Bernard | Geschäftsführer | Enniskerry 48 Eagle Valley Wicklow Ireland (Republic Of) | Ireland | Irish | 179097930001 | |||||||||||||
| GLENNANE, David | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London Level 7 | Republic Of Ireland | Irish | 170639100001 | |||||||||||||
| MCNALLY, Simon John | Geschäftsführer | Sulby Glen IM7 2AZ Sulby Glen Moar House Isle Of Man | Isle Of Man | British | 65751480002 | |||||||||||||
| MCNALLY, Simon John | Geschäftsführer | Glenmoar House Sulby Glen, Sulby IM7 2AZ Ramsey Isle Of Man | Isle Of Man | British | 65751480002 | |||||||||||||
| MCNALLY, Simon John | Geschäftsführer | Glenmoar House Sulby Glen, Sulby IM7 2AZ Ramsey Isle Of Man | Isle Of Man | British | 65751480002 | |||||||||||||
| MILLS, Joshua Ananda | Geschäftsführer | Old Jewry 7th Floor EC2R 8DU London 11 Uk England | Usa | American | 123070620001 | |||||||||||||
| RUHAN, Andrew Joseph | Geschäftsführer | High Trees Shire Lane Horn Hill SL9 0QY Chalfont St Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | 154690700001 | |||||||||||||
| SCOTT, Stephen Derrick | Geschäftsführer | Wood Vale Forest Hill SE23 3DT London 65 United Kingdom | United Kingdom | British | 222396530001 | |||||||||||||
| SODZAWICZNY, Franek Jan | Geschäftsführer | Woodbury Farm Bank Lane WR6 6LR Little Witley Worcestershire | England | British | 146533810001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SENTRUM SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust, Inc | 06. Apr. 2016 | St Paul Street Suite 820 21202 Baltimore 7 Maryland Usa | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SENTRUM SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2011 Geliefert am 21. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 02. Juni 2011 Geliefert am 04. Juni 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenant's interest in all monies standing to the credit of the account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. März 2010 Geliefert am 04. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 15. Apr. 2009 Geliefert am 24. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The additional charged contracts, the contract proceeds and the insurance proceeds derived from the additional charged contracts. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amended and restated debenture | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 04. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over account balances | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 26. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights, title and interest in and to the account balances by way of first fixed charge and by way of first floating charge see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and charge of contracts relating to services agreements | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 26. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights, title and interest in the charged contracts, the contract proceeds and the insurance proceeds, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and variation | Erstellt am 16. Mai 2008 Geliefert am 03. Juni 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (and each qatar 2 obligor to the chargee) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The parties amend and restate the watford facility agreement and the woking facility agreement and to vary the watford security documents and the woking security documents in the manner set out in schedules 3 and 4, 5, 6 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental assignment | Erstellt am 11. Apr. 2008 Geliefert am 16. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from sentrum limited to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its interest in each new assigned agreement, being a services agreement dated 10 april 2008 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fourth deed of variation | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 13. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge over the watford property, all shares of ssl and sl and the shares of shl. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third deed of variation | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 12. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge over the watford property, all shares of ssl and sl and the shares of shl. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third deed of variation | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 12. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge over the croydon property, all shares of ssl and sl and the shares of shl. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second deed of variation | Erstellt am 21. Dez. 2007 Geliefert am 09. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All obligations and credit facilities of £59,750,000 to sl; fixed charge over the croydon property, all shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second deed of variation | Erstellt am 21. Dez. 2007 Geliefert am 09. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All obligations and credit facilities of £59,750,000 to sl; fixed charge over the croydon property, all shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 18. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest in each assigned agreement and all assigned income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. März 2007 Geliefert am 03. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture (variation) | Erstellt am 14. März 2007 Geliefert am 04. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By the original debenture the chargors granted security (including a fixed charge over the croydon data centre) in favour of investec. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Jan. 2007 Geliefert am 25. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property at unit b prologis park beddington lane croydon surrey t/n SGL6. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0