CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED

CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05968063
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Belvedere
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Stewart David Hamilton als Sekretär am 31. Juli 2020

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Zachary Jason Lewy als Geschäftsführer am 21. Okt. 2019

    1 SeitenTM01

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Paul David Cooper als Geschäftsführer am 09. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    6 SeitenAA

    Ernennung von Paul David Cooper als Direktor am 01. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Memmott als Geschäftsführer am 01. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Capquest Group Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Withdrawal of a person with significant control statement on 09. Nov. 2017

    2 SeitenPSC09

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Philip Sinclair Marsland als Geschäftsführer am 31. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Zachary Jason Lewy am 19. Apr. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Robert Memmott am 25. Mai 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Zachary Jason Lewy am 25. Mai 2017

    2 SeitenCH01

    Zweite Einreichung für die Ernennung von Robert Memmott zum Geschäftsführer

    6 SeitenRP04AP01

    Ernennung von Philip Sinclair Marsland als Direktor am 03. Jan. 2017

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROCHFORD, Lee Michael
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    United KingdomBritish178559360002
    FLYNN, William John
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Sekretär
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    British170804630001
    HAMILTON, Stewart David
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    England
    Sekretär
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    England
    British193822700001
    LEE, Robert James
    4 Sir Toby Belch Drive
    Warwick Gates
    CV34 6GP Warwick
    Warwickshire
    Sekretär
    4 Sir Toby Belch Drive
    Warwick Gates
    CV34 6GP Warwick
    Warwickshire
    British33494670003
    MCQUILKIN, Paul
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Sekretär
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    British71256440003
    AINSWORTH, Keith
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    United KingdomBritish46161840001
    ASHTON, Helen Jane
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish172248290002
    BRUNAULT, Mark Andrew
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    United KingdomUsa98296920003
    COOPER, Paul David
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    United KingdomBritish178892050001
    COX, Kathryn Ann
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Fleet 27
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Fleet 27
    Hampshire
    United KingdomBritish128558800001
    DANIELS, Michael
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish57006390004
    DLUTOWSKI, Joseph Arthur
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    SwitzerlandSt Kitts/Nevis66506120008
    DRURY, Thomas Waterworth
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    Geschäftsführer
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United KingdomBritish/Canadian182036150001
    FLYNN, William John
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish172238860001
    LEE, Robert James
    4 Sir Toby Belch Drive
    Warwick Gates
    CV34 6GP Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    4 Sir Toby Belch Drive
    Warwick Gates
    CV34 6GP Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish33494670003
    LEWY, Zachary Jason
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    England
    Geschäftsführer
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    England
    EnglandBritish,American306722890001
    MARSLAND, Philip Sinclair
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    United KingdomBritish231219640001
    MCQUILKIN, Paul
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fleet 27 Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish71256440003
    MEMMOTT, Robert
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    England
    Geschäftsführer
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    England
    EnglandBritish165035510014
    MILES, Paul Lewis
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fleet 27
    Rye Close
    GU51 2QQ Fleet
    Hampshire
    UkBritish180382910001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    12 Booth Street
    M2 4AW Manchester
    Belvedere
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4936030
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    07. Nov. 201608. Nov. 2017Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat CAPQUEST INVESTMENTS 2 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture (northern ireland)
    Erstellt am 26. Aug. 2011
    Geliefert am 09. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 26. Aug. 2011
    Geliefert am 09. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 26. Aug. 2011
    Geliefert am 07. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to an asset finance lender and/or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Aug. 2011
    Geliefert am 07. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to an asset finance lender and/or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 17. Nov. 2008
    Geliefert am 02. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any memebr of the group to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 17. Nov. 2008
    Geliefert am 02. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 17. Nov. 2008
    Geliefert am 02. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and accession
    Erstellt am 11. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and accession
    Erstellt am 11. Sept. 2007
    Geliefert am 21. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and accession
    Erstellt am 11. Sept. 2007
    Geliefert am 21. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 14. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 14. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Nov. 2006
    Geliefert am 17. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named there in to dam invest sarl, ec investments sarl and the chargee (together, the security beneficiaries) (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, Niederlassung Luxemburg
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 07. Nov. 2006
    Geliefert am 17. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named there in to dam invest sarl, ec investments sarl and the chargee (together, the security beneficiaries) (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, Niederlassung Luxemburg
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2006
    Geliefert am 17. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named there in to dam invest sarl, ec investments sarl and the chargee (together, the security beneficiaries) (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, Niederlassung Luxemburg
    • Dresdner Bank Ag, Niederlassung Luxemburg
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0