TISSUE REGENIX GROUP LTD
Überblick
| Unternehmensname | TISSUE REGENIX GROUP LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05969271 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TISSUE REGENIX GROUP LTD?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TISSUE REGENIX GROUP PLC | 28. Juni 2010 | 28. Juni 2010 |
| OXECO PLC | 19. Okt. 2006 | 19. Okt. 2006 |
| OXECO TWO PLC | 17. Okt. 2006 | 17. Okt. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Okt. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 31. Okt. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Okt. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 08. Jan. 2026
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Notification of Harwood Private Equity Vi Lp as a person with significant control on 08. Jan. 2026 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 21. Jan. 2026 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Ms Judith Anne Madden als Direktor am 05. Jan. 2026 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Geoffrey Joseph Fitzhugh Gorman als Direktor am 13. Jan. 2026 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Sturm als Direktor am 13. Jan. 2026 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von George Brian Phillips als Geschäftsführer am 09. Jan. 2026 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shervanthi Homer Vanniasinkam als Geschäftsführer am 08. Jan. 2026 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | CERT10 | ||||||||||||||||||
Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2 Seiten | RR02 | ||||||||||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 42 Seiten | MAR | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 059692710006, erstellt am 23. Dez. 2025 | 67 Seiten | MR01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Okt. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Miss Kirsten Mary Lund als Direktor am 17. Okt. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Ray Lee als Geschäftsführer am 15. Okt. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Jay Charles Lecoque als Direktor am 04. Sept. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Michael Phillips als Geschäftsführer am 05. Sept. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Martin Glenn als Geschäftsführer am 05. Sept. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Claiborne Cocke als Geschäftsführer am 31. Juli 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 85 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Okt. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 19. Juni 2024
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUND, Kirsten Mary | Sekretär | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | 265561660001 | |||||||
| GORMAN, Geoffrey Joseph Fitzhugh | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 344465820001 | |||||
| LECOQUE, Jay Charles | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 340092570001 | |||||
| LUND, Kirsten Mary | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 341789650001 | |||||
| MADDEN, Judith Anne | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 344488970001 | |||||
| STURM, Timothy James | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 142871130003 | |||||
| BARKER, Michael Denis | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 219336440001 | |||||||
| BELOW, Paul | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 242703280001 | |||||||
| BRETHERTON, Michael Anthony | Sekretär | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | 152329670001 | |||||||
| DEVLIN, Paul | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 221870670001 | |||||||
| GORDON, Nigel Raymond | Sekretär | 22 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | British | 34955700003 | ||||||
| JEFFERSON, Ian David | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | British | 160870460001 | ||||||
| JONES, Gareth Hywel | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 252392970001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| AUBREY, Alan John | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 77053350002 | |||||
| BARKER, Michael Denis | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 160393640002 | |||||
| BRETHERTON, Michael Anthony | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 114056040001 | |||||
| COCKE, David Claiborne | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 279282120001 | |||||
| COULDWELL, Steven | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 180689210001 | |||||
| DAVIES, Stephen Graham, Professor | Geschäftsführer | Wellington Square OX1 2JD Oxford University Offices Oxfordshire | United Kingdom | British | 136712640001 | |||||
| DEVLIN, Paul John | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 113889280002 | |||||
| FIELDING, Alison Margaret, Dr | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 97075620002 | |||||
| GLENN, Jonathan Martin | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United Kingdom | British | 148251560003 | |||||
| GORDON, Nigel Raymond | Geschäftsführer | 22 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 34955700003 | |||||
| GREWAL, Randeep Singh | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 180652980001 | |||||
| HALL, Gordon James | Geschäftsführer | Aberkirk House Dumblehole Lane Ashford Carbonel SY8 4DF Ludlow Shropshire | England | British | 56289410002 | |||||
| HOMER VANNIASINKAM, Shervanthi, Professor | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 208704030001 | |||||
| JEFFERSON, Ian David | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 80245080002 | |||||
| JONES, Gareth Hywel | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United Kingdom | British | 59032980002 | |||||
| LEE, Daniel Ray | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 277099400001 | |||||
| MILLER, Alan Jonathan Richard | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 127433380001 | |||||
| NORWOOD, David Robert | Geschäftsführer | 53 St John's Street OX1 2LQ Oxford | British | 83359010002 | ||||||
| ODELL, Antony Ruben | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 152306920001 | |||||
| PHILLIPS, George Brian | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 118807400001 | |||||
| PHILLIPS, Trevor Michael | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 199317050002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harwood Private Equity Vi Lp | 08. Jan. 2026 | Stratton Street W1J 8LD London 6 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Invesco Limited | 24. Juli 2017 | Perpetual Park Drive RG9 1HH Henley On Thames Perpetual Park Oxfordshire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Woodford Investment Management Ltd | 24. Juli 2017 | Garsington Road OX4 2HN Oxford 9400 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für TISSUE REGENIX GROUP LTD?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 12. Nov. 2019 | 08. Jan. 2026 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0