R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED

R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameR & L PROPERTIES NO 1 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05985661
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED?

    • (5540) /

    Wo befindet sich R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KILT PROPCO LIMITED01. Nov. 200601. Nov. 2006

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. Juni 2007

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    40 Seiten4.72

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Jan. 2015

    40 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Sept. 2014

    41 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. März 2014

    41 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Sept. 2013

    36 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Mark Grunnell als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Aaron Brown als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. März 2013

    36 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Sept. 2012

    35 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Sept. 2011

    77 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Michael Ingham als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    33 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Juli 2011

    44 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    83 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    10 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor Leconfield House Curzon Street London W1J 5JA* am 19. Jan. 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Wer sind die Geschäftsführer von R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TCHENGUIZ, Robert
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    Geschäftsführer
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    EnglandBritish74322720004
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    JAYASEKERA, Rajni
    Flat 20 Lords View
    St Johns Wood Road
    NW8 7HJ London
    Sekretär
    Flat 20 Lords View
    St Johns Wood Road
    NW8 7HJ London
    British114397040001
    BANKES JONES, Henry
    The Old Rose
    Littlebury Green
    CB11 4XB Saffron Waldon Cambridge
    Essex
    Cb11 4xb
    Geschäftsführer
    The Old Rose
    Littlebury Green
    CB11 4XB Saffron Waldon Cambridge
    Essex
    Cb11 4xb
    British116570350001
    BLOOD, Jeremy John Foster
    4 Burgess Terrace
    EH9 2BD Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    4 Burgess Terrace
    EH9 2BD Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish106494920001
    BROWN, Aaron Maxwell
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    Geschäftsführer
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    United KingdomBritish98928830002
    CRAWSHAY, William John Julian
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritish79182280001
    DRAPER, John Patrick
    The Moor
    Coleorton
    LE67 8GE Coalville
    138
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Moor
    Coleorton
    LE67 8GE Coalville
    138
    Leicestershire
    United KingdomBritish147073290001
    GRUNNELL, Mark
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    Geschäftsführer
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    United KingdomBritish94144450002
    MACKERRON, John Charles Alexander
    15 Greenfield Crescent
    EH14 7HD Balerno
    Midlothian
    Geschäftsführer
    15 Greenfield Crescent
    EH14 7HD Balerno
    Midlothian
    British62281010001
    MOORE, Christopher John
    Harrington Road
    Loddington
    NN14 1JZ Kettering
    69
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Harrington Road
    Loddington
    NN14 1JZ Kettering
    69
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish136853310001
    MORSE, Stella Helen
    Achnacarry
    Trochry
    PH8 0DY Dunkeld
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Achnacarry
    Trochry
    PH8 0DY Dunkeld
    Perthshire
    ScotlandBritish100130360001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Geschäftsführer
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002

    Hat R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignation of rents
    Erstellt am 11. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the rental income (for details of properties charged in relation to the rental income please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Capital Mortgage Servicing Limited (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rents
    Erstellt am 11. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the rental income (for details of properties charged in relation to the rental income please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Capital Mortgage Servicing Limited (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    For details of properties charged please refer to form 395,
    Erstellt am 04. Juni 2007
    Geliefert am 13. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Capital Mortgage Servicing Limited (Facility Agent)
    Transaktionen
    • 13. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 21 june 2007 and
    Erstellt am 02. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in respect of the properties, abbotsford inn , nithsdale crescent, bearsden t/no DMB69355. Alexandra, 468 duke street, glasgow t/no GLA154245. Allander, 1 glasgow road, glasgow t/no DMB68916. For details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Capital Mortgage Servicing Limited (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 21 june 2007 and
    Erstellt am 02. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in respect of the properties, abbotsford inn, nithsdale crescent, bearsden t/no DMB69355. Alexandra, 468 duke street, glasgow t/no GLA154245. Allander, 1 glasgow road, glasgow t/no DMB68916. For details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Capital Mortgage Servicing Limited (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rents
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 02. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in and to the rental income in respect of the properties being abbotsford inn, nithsdale crescent, bearsden t/no DMB69355; alexandra, 468 duke street, glasgow t/no GLA154245 and allander, 1 glasgow road, glasgow t/no DMB68916 (for details of further property charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rents
    Erstellt am 16. Jan. 2007
    Geliefert am 02. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in and to the rental income in respect of the properties being airlie arms hotel, 4 st malcolms wynd, kirriemuir t/no ANG42266; carter's rest, abbey place, jedburgh t/no ROX4634 and commercial inn, cross street, campbeltown t/no ARG12785 (for details of further property charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 25TH january 2007 and
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 02. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Airlie arms hotel, 4 st malcolms wynd, kirriemuir t/no ANG42266; carter's rest, abbey place, jedburgh t/no ROX4634 and commercial inn, cross street, campbeltown t/no ARG12785 (for details of further property charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 25TH january 2007 and
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 02. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects being abbotsford inn, nithsdale crescent, bearsden t/no DMB69355; alexandra, 468 duke street, glasgow t/no GLA154245 and allander, 1 glasgow road, glasgow t/no DMB68916 (for details of further property charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 04. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The caledonian (formerly barcode), 17 botchergate, carlisle f/h t/no CU166351. Three travellers, wood lane, beacontree, romford f/h t/no EGL415530. Malborough arms, 163 mawney road, romford f/h t/no EGL415881. For details of further property charged please refer to form 395, including all buildings, fixtures and plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 04. Dez. 2006
    Geliefert am 12. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H the caledonian (formerly barcode) 17 botchergate carlisle t/no CU166351,f/h three travellers wood lane beacontree romford t/no EGL415530,marlborough arms 163 mawney road romford t/no EGL415881 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat R & L PROPERTIES NO 1 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Jan. 2015Ende der Verwaltung
    11. Jan. 2011Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Po Box 810
    EC4A 3WA Athene Place
    66 Shoe Lane London
    Praktiker
    Deloitte & Touche Llp
    Po Box 810
    EC4A 3WA Athene Place
    66 Shoe Lane London
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praktiker
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    2
    DatumTyp
    09. Jan. 2015Beginn der Liquidation
    21. Juni 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praktiker
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    John Charles Reid
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0