CSC1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CSC1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05988511 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CSC1 LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich CSC1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CSC1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CSC1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam Warwickshire CV47 2DL zum Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 04. Feb. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Frank Theodore Sagnier am 01. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Frank Theodore Sagnier als Direktor am 18. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rodney Peter Cousens als Geschäftsführer am 18. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Rashid Ismail Varachia als Direktor am 18. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CSC1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARACHIA, Rashid | Sekretär | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London Grant Thornton Uk Llp | 175103970001 | |||||||
| SAGNIER, Frank Theodore | Geschäftsführer | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London Grant Thornton Uk Llp | England | French | 196390590001 | |||||
| VARACHIA, Rashid | Geschäftsführer | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London Grant Thornton Uk Llp | England | British | 170342880001 | |||||
| MARTIN, Paul Santo | Sekretär | Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam CV47 2DL Warwickshire | 154572200001 | |||||||
| PARSONS, Simon Lawrence | Sekretär | Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam CV47 2DL Warwickshire | British | 161173620001 | ||||||
| STOCKTON, Neil David | Sekretär | Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam CV47 2DL Warwickshire | 172872130001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| COUSENS, Rodney Peter | Geschäftsführer | Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam CV47 2DL Warwickshire | United Kingdom | British | 42266870001 | |||||
| PARSONS, Simon Lawrence | Geschäftsführer | Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam CV47 2DL Warwickshire | England | British | 161173620001 | |||||
| WILLIAMS, Anthony Ronald | Geschäftsführer | 17 Burlington Street BA1 2SB Bath Avon & Somerset | England | British | 72612720001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CSC1 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Codemasters Software Company Limited | 06. Apr. 2016 | Stoneythorpe CV47 2DL Southam Codemasters Campus Warwickshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CSC1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 2012 Geliefert am 21. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Sept. 2009 Geliefert am 15. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Sept. 2009 Geliefert am 15. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to bank of scotland PLC under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Okt. 2008 Geliefert am 21. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or codemasters to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2006 Geliefert am 09. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or codemasters to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CSC1 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0