KBC CHISWICK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKBC CHISWICK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05992192
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KBC CHISWICK LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich KBC CHISWICK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    268 Bath Road
    SL1 4DX Slough
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KBC CHISWICK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KBC CHISWICK LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für KBC CHISWICK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Ernennung von Mr Peter David Edward Gibson als Direktor am 10. Apr. 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Richard Morris als Direktor am 10. Apr. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Marie Elizabeth Edwards als Sekretär am 10. Apr. 2015

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Lyric Square London W6 0NB England zum 268 Bath Road Slough SL1 4DX am 22. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Michael James Kingshott als Geschäftsführer am 10. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 22 Long Acre London WC2E 9LY zum 268 Bath Road Slough SL1 4DX am 26. Nov. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 20. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 22 Long Acre London WC2E 9LY United Kingdom zum 20 Hanover Square London W1S 1JY geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    20 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Marie Elizabeth Edwards als Sekretär am 18. Dez. 2013

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Alexander als Sekretär am 18. Dez. 2013

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Serviced Office Group 22 Long Acre London WC2E 9LY England am 04. Dez. 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Paul Alexander als Direktor am 17. Okt. 2013

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Alan Douglas Pepper als Direktor am 17. Okt. 2013

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Alexander als Sekretär am 17. Okt. 2013

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Jane Scannell als Geschäftsführer am 17. Okt. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Jane Scannell als Sekretär am 17. Okt. 2013

    1 SeitenTM02

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Restatement agreement 07/08/2013
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von KBC CHISWICK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    GIBSON, Peter David Edward
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    MORRIS, Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish190653350001
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    ALEXANDER, Paul
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Sekretär
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183163800001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Sekretär
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    Sekretär
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    185429750001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    Sekretär
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    152617650002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    CORPET, Antoine
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    Geschäftsführer
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    French131276650001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    Geschäftsführer
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritish76547250001
    KINGSHOTT, Michael James
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish83713020002
    PETRIE, Roderick Mckenzie
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    ScotlandBritish1246700004
    ROWBOTTOM, Alex James
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    British135706810001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish154659960001
    TASCHLER, Jeffery
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    Geschäftsführer
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    United States135708370001
    WAKELIN, James David
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    Geschäftsführer
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    British92221010001
    WASHINGTON, Robert Francis
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    Geschäftsführer
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    Australian120776550001

    Hat KBC CHISWICK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Turnham green terrace, london t/no AGL193916. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Mai 2013Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 16. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Turnham green terrace, london t/no AGL193916 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Mai 2013Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 16. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 28. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    Berechtigte Personen
    • West Register Number 2 Limited
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Mai 2013Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 16. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of substituted security relating to legal charge dated 9 may 2007
    Erstellt am 20. Okt. 2008
    Geliefert am 22. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Upperparts gable house 18-28 turnham green terrace london t/no AGL190117 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juni 2008
    Geliefert am 02. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property more fully detailed within the deed of variation of lease of premises at upper parts of gable house, 18-22 turnham green terrace, london fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2007
    Geliefert am 10. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a upper parts of gable house 18-28 turnham green terrace london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 18. Dez. 2006
    Geliefert am 21. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0