SEEBECK 133 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SEEBECK 133 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05993870 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SEEBECK 133 LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SEEBECK 133 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SEEBECK 133 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AXIS GROUP INTEGRATED SERVICES LIMITED | 03. Mai 2016 | 03. Mai 2016 |
SEEBECK 133 LIMITED | 03. Mai 2016 | 03. Mai 2016 |
AXIS GROUP INTEGRATED SERVICES LIMITED | 16. Apr. 2013 | 16. Apr. 2013 |
LPM GROUP LIMITED | 09. Nov. 2006 | 09. Nov. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SEEBECK 133 LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2022 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2023 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2021 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SEEBECK 133 LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Nov. 2023 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 23. Nov. 2023 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Nov. 2022 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für SEEBECK 133 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. März 2024 | 23 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor Suite River House Maidstone Road Sidcup Kent DA14 5RH zum 1 Radian Court Knowlhill Milton Keynes MK5 8PJ am 25. Apr. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 9 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. März 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Kathy Mcdermott als Direktor am 27. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Una Irene Geraldine Ni Mhurchu als Direktor am 01. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Una Irene Geraldine Ni Mhurchu als Sekretär am 01. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Patrick Kennedy als Geschäftsführer am 31. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Declan Doyle am 04. Juli 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Kenneth Giles als Geschäftsführer am 31. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 10 Norwich Street London EC4A 1BD verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 10 Norwich Street London EC4A 1BD geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Kenneth Giles am 29. Juni 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Kenneth Giles als Sekretär am 03. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SEEBECK 133 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI MHURCHU, Una Irene Geraldine | Sekretär | Unit 3 Swords Business Park Swords K67 X971 Hilton House Dublin Ireland | 299120810001 | |||||||
DOYLE, Declan | Geschäftsführer | Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes 1 | Ireland | Irish | Company Director | 134294270022 | ||||
MCDERMOTT, Kathy | Geschäftsführer | Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes 1 | Ireland | Irish | Accountant | 307279650001 | ||||
NI MHURCHU, Una Irene Geraldine | Geschäftsführer | Unit 3 Swords Business Park Swords K67 X971 Hilton House Dublin Ireland | Ireland | Irish | Solicitor | 299128190001 | ||||
GILES, Simon Kenneth | Sekretär | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | 201331810001 | |||||||
PERFECT, Ian | Sekretär | 1 Hostier Close ME2 1ES Halling Kent | British | Accountant | 94981580001 | |||||
SAUNDERS, Mark | Sekretär | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | 167230770001 | |||||||
SCOBIE, James Martin | Sekretär | 1 Eastcote BR6 0AU Orpington Kent | British | Finance Director | 73982880001 | |||||
STRATFORD, Frederick | Sekretär | Five Arches Business Park Maidstone Road DA14 5AG Sidcup 4 Crayside Kent | 162103690001 | |||||||
MH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Staple Court 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London | 123667200001 | |||||||
BOGG, Dyson Peter Kelly | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | United Kingdom | Australian | Director | 135422570001 | ||||
BOYLE, Eugene Daniel | Geschäftsführer | Teach Ban Parkside Drive PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 86492920001 | ||||
BRADFORD, Richard James | Geschäftsführer | Holcombe House Olney Road MK46 5BX Emberton Buckinghamshire Bucks | United Kingdom | British | Company Director | 72452740004 | ||||
BURDETT, Roger Leonard | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | United Kingdom | British | Director | 163337290001 | ||||
EGAN, Paul | Geschäftsführer | 27 Sistova Road Balham SW12 9QR London | United Kingdom | British | Director | 141719660001 | ||||
FETHERSTON DILKE, Michael Charles | Geschäftsführer | Maxstoke Castle B46 2RD Coleshill Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 88087050001 | ||||
GILES, Simon Kenneth | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | British | Finance Director | 196768780001 | ||||
HOWROYD, David Rowan | Geschäftsführer | Bay Tree House East Street TN20 6TY Mayfield East Sussex | British | Co Director | 72333480002 | |||||
KENNEDY, Michael Patrick | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | Irish | Company Director | 253530690001 | ||||
LEVINE, Jonathan Stephen | Geschäftsführer | Belsize Lane NW3 5AD London 11 England | England | British | Company Director | 19162600001 | ||||
MUNDELL, David John | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | United Kingdom | British | Director | 57745430002 | ||||
PERFECT, Ian | Geschäftsführer | 1 Hostier Close ME2 1ES Halling Kent | United Kingdom | British | Accountant | 94981580001 | ||||
ROBSON, Ryan James Henry | Geschäftsführer | 34 Wandle Road SW17 7DW London | United Kingdom | British | Investment Director | 51010060002 | ||||
SAUNDERS, Mark Ian | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | England | British | Group Finance Director | 139588670003 | ||||
SCOBIE, James Martin | Geschäftsführer | 1 Eastcote BR6 0AU Orpington Kent | United Kingdom | British | Director | 73982880001 | ||||
STRATFORD, Frederick Anthony | Geschäftsführer | Five Arches Business Park Maidstone Road DA14 5AG Sidcup 4 Crayside Kent | United Kingdom | British | Company Director | 151871680001 | ||||
WHITTLE, Kevin Richardson | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | United Kingdom | British | Director | 162110720001 | ||||
WILLIAMS, Mark Llewellyn | Geschäftsführer | Blomfield Road Maida Vale W9 2PA London 63h | United Kingdom | British | Investment Banker | 133256890001 | ||||
MH DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 Great James Street WC1N 3DR London | 900021090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SEEBECK 133 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis Group Integrated Services Limited | 01. Apr. 2020 | Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor, River House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr David Mundell | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Simon Giles | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Roger Leonard Burdett | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Jonathan Stephen Levine | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SEEBECK 133 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 06. Dez. 2018 Geliefert am 12. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 30. Aug. 2016 Geliefert am 01. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of insurance policy | Erstellt am 06. Sept. 2010 Geliefert am 21. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to a finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Policy. 1 june 2009 aegon scottish equitable L0109193623 £1,000,000 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of insurance policy | Erstellt am 06. Sept. 2010 Geliefert am 21. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to a finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Policy. 20 august 2009 aegon scottish equitable L019528803 £1,000,000 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of life policy | Erstellt am 23. Feb. 2009 Geliefert am 24. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy - date of policy: 18/12/2008 insurance company: aegon scottish equitable p/no. L0197085023 sum assured (exclusive of bonus: £1,000,000.00 name of life assured: david howroyd with full title guarantee together with all money including bonuses, that have accrued or may become payable see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of life policy | Erstellt am 23. Feb. 2009 Geliefert am 24. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy - date of policy: 22/01/2009 insurance company: aegon scottish equitable p/no. L0196975023 sum assured (exclusive of bonus: £500,000.00 name of life assured: eugene boyle with full title guarantee together with all money including bonuses, that have accrued or may become payable see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 05. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed & floating charge | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 04. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 04. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SEEBECK 133 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0