CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06006147 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Nov. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Marshall als Direktor am 01. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Matthew Syers als Geschäftsführer am 01. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Terence Millington als Geschäftsführer am 01. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alan Matthew Syers am 22. Nov. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Terence Millington am 22. Nov. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 23. März 2016
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSHALL, Robert | Sekretär | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | 165897820001 | |||||||
| EVANS, Roderick Michael | Geschäftsführer | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | United Kingdom | British | 40175270005 | |||||
| MARSHALL, Robert | Geschäftsführer | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | United Kingdom | British | 190577840001 | |||||
| JOBBINS, Stuart | Sekretär | 16 Riverside Avenue LS21 2RT Otley West Yorkshire | British | 108146440001 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Chapman House Chapman Square HG1 2SQ Harrogate Flat 9 North Yorkshire | United Kingdom | British | 63940900003 | |||||
| MARCUS, Ian | Geschäftsführer | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | England | British | 85847920002 | |||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Geschäftsführer | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | United Kingdom | British | 58693930003 | |||||
| SYERS, Alan Matthew | Geschäftsführer | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | England | British | 65588650002 | |||||
| TURNER, Philip Arthur | Geschäftsführer | Red Roofs 2 Mulberry Garth Thorp Arch LS23 7AF Wetherby West Yorkshire | British | 66424440001 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Michael White Evans | 06. Apr. 2016 | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Jersey | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mrs Helga Ingeborg Evans | 06. Apr. 2016 | Millshaw Leeds LS11 8EG West Yorkshire | Nein | ||||||||||
Nationalität: German Staatsangehörigkeit: Monaco | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Sanne Group Plc | 06. Apr. 2016 | Castle Street JE4 5UT St Helier 13 Jersey | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CITYGATE DEVELOPMENTS NO.2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H victoria mills wellington bridge street leeds west yorkshire t/n WYK140446 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south side of wellington street leeds west yorkshire partly comrised within t/n WYK219237 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999 and | Erstellt am 26. Feb. 2007 Geliefert am 07. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0