BRIGHTSEA EOI LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BRIGHTSEA EOI LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 06006543 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRIGHTSEA EOI LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich BRIGHTSEA EOI LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Wigmore Street London W1U 1PB |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRIGHTSEA EOI LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
EVANS OFFICE INVESTMENTS LIMITED | 22. Nov. 2006 | 22. Nov. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRIGHTSEA EOI LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRIGHTSEA EOI LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2011 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2010 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 22. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 22. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403b | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRIGHTSEA EOI LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870001 | ||||||||||
BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | 57/63 Line Wall Road Gibraltar | Gibraltar | British | Solicitor | 69435160001 | ||||||||
WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | Barrister-At-Law | 80132540006 | ||||||||
TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
JOBBINS, Stuart | Sekretär | 16 Riverside Avenue LS21 2RT Otley West Yorkshire | British | 108146440001 | ||||||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 63940900001 | ||||||||
MCKENDRICK, Charles | Geschäftsführer | St Anns Main Street LS22 5EB Kirk Deighton North Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 173983190001 | ||||||||
MILLINGTON, Paul Terence | Geschäftsführer | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | United Kingdom | British | Accountant | 58693930003 | ||||||||
TURNER, Philip Arthur | Geschäftsführer | Red Roofs 2 Mulberry Garth Thorp Arch LS23 7AF Wetherby West Yorkshire | British | Company Director | 66424440001 | |||||||||
REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 | |||||||||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Hat BRIGHTSEA EOI LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Tenth supplemental trust deed | Erstellt am 24. Dez. 2008 Geliefert am 07. Jan. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a hume house, wade lane, leeds t/no WYK192637. F/h property k/a 52 & 54-58 high street, hull t/no HS337572 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security agreement | Erstellt am 24. Dez. 2008 Geliefert am 07. Jan. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Unit 6 fradley park, lancaster road, lichfield t/no SF372758 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security presented for registration in scotland on 1 october 2007 and | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 13. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Two office premises known as norseman house and westcott house at ferry muir south queensferry t/n WLN39514, the site of a burger king restaurant at ferry muir south queensferry t/n WLN39513 and the site of a frankie & benny restaurant at ferry muir south queensferry t/n WLN39515. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Norseman house and westcott house at ferry muir, south queensferry t/n WLN39514, burger king restaurant at ferry muir, south queensferry t/n WLN39513 and frankie & benny restaurant at ferry muir, south queensferry t/n WLN39515. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignation of rents | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Whole right title and interest in and to the rental income in respect of the properties and under any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 27. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Victoria park house victoria road staffordshire stafford f/h t/n SF415289 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of covenant and charge | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 11. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben United house piccadilly york t/n NYK29415; stonebow house the stonebow york t/n NYK36956; george house/stanford house 16-18 george street piccadilly york t/n NYK280364 and mill house troy road horsforth leeds west yorkshire t/n WYK63829; all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery and benefit of all leases. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H hume house wade lane leeds west yorkshire t/n WYK192637 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H cannon house apex way leeds west yorkshire t/n WYK307583 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land on the east of high street kingston upon hull partly comprised within t/n HS94367 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the east side of tiviot dale stockport greater manchester t/n GM622612 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 27TH march 2007 and | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All and whole the subjects forming the site of a frankie & benny restaurant at ferry muir, south queensferry. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 27TH march 2007 and | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All and whole the subjects forming the site of a burger king restaurant at ferry muir, south queensferry t/no WLN39513. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 27TH march 2007 and | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All and whole the subjects forming the site of the norseman house / westcott house office at ferry muir, south queensferry. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession to composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999 and | Erstellt am 26. Feb. 2007 Geliefert am 07. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0