ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 06028351 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 City Square LS1 2AL Leeds |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HAMSARD 3049 LIMITED | 14. Dez. 2006 | 14. Dez. 2006 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 19 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Number One Great Exhibition Way Kirkstall Forge Leeds LS5 3BF United Kingdom zum 1 City Square Leeds LS1 2AL am 20. Feb. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Jan. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Peter Buchan als Geschäftsführer am 19. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Zenith Vehicle Contracts Group Limited as a person with significant control on 20. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Anglia House Holly Park Mills Calverley Leeds West Yorkshire LS28 5QS zum Number One Great Exhibition Way Kirkstall Forge Leeds LS5 3BF am 20. Nov. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Patrick James Rawnsley als Sekretär am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 060283510010, erstellt am 29. Juni 2017 | 25 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sally Elizabeth Jones als Sekretär am 30. Juni 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Peter Buchan am 17. Mai 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 060283510009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Longstreth Thompson als Geschäftsführer am 06. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAWNSLEY, Patrick James | Sekretär | City Square LS1 2AL Leeds 1 | 236009570001 | |||||||
BUTLER, Robert Alan | Geschäftsführer | City Square LS1 2AL Leeds 1 | United Kingdom | British | Director | 168472630001 | ||||
PHILLIPS, Mark Trevor, Mr. | Geschäftsführer | City Square LS1 2AL Leeds 1 | England | British | Finance Director | 60778940002 | ||||
JONES, Sally Elizabeth | Sekretär | Anglia House Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds West Yorkshire | British | 148593510001 | ||||||
TURK, Adam John | Sekretär | 3 Underwood Court Station Road Burley In Wharfedale LS29 7NQ Ilkley West Yorkshire | British | 59187050003 | ||||||
HAMMONDS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 900026750001 | |||||||
BUCHAN, Timothy Peter | Geschäftsführer | Great Exhibition Way LS5 3BF Kirkstall Forge Number One Leeds United Kingdom | England | British | Director | 109172820004 | ||||
COPE, Andrew Iain | Geschäftsführer | Anglia House Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds West Yorkshire | England | British | Managing Director | 130869380002 | ||||
JEROME, Philip Victor | Geschäftsführer | 12 The Warren WP7 7DX Radlett Little Dormers Hertfordshire | England | British | Director | 179904890001 | ||||
LESLIE, Gerard | Geschäftsführer | Lairds Gate Bothwell G71 7HR Glasgow 31 | British | Director | 131072190001 | |||||
THOMPSON, Matthew Longstreth | Geschäftsführer | Holly Park Mills Calverley LS28 5QS Leeds Anglia House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Commercial Officer | 204204250001 | ||||
HAMMONDS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 900026740001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenith Vehicle Contracts Group Limited | 06. Apr. 2016 | Great Exhibition Way Kirkstall Forge LS5 3BF Leeds Number One United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 29. Juni 2017 Geliefert am 18. Juli 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 16. Okt. 2013 Geliefert am 26. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed to a debenture | Erstellt am 17. Juni 2011 Geliefert am 28. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben With effect from and including the date of the supplimental deed, the debenture was amended as follows: (a) clause 3.4(g) was deleted and replaced; (b) clause 3.5 of the debenture was amended; (c) clause 10.6 of the debenture was amended see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security deed of accession | Erstellt am 13. Sept. 2010 Geliefert am 21. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Mai 2008 Geliefert am 13. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment over warranties | Erstellt am 08. Mai 2008 Geliefert am 10. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The benefit of each of the warranties contained within the acquisition agreement dated 08/05/2008 all rights titles benefits monies receivable and interests of the company see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of securities | Erstellt am 08. Mai 2008 Geliefert am 10. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns its whole right title and benefit to the securities and all rights attaching to the securities see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Juni 2007 Geliefert am 12. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment over warranties | Erstellt am 07. Juni 2007 Geliefert am 12. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest present and future to in and arising out or in respect of the warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of securities | Erstellt am 07. Juni 2007 Geliefert am 12. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Its whole right, title and benefit to:- any stocks, shares, bonds, warrants or other securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ZENITH INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0