GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED

GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06065044
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. März 2016

    Kapitalaufstellung am 22. März 2016

    • Kapital: GBP 1,001
    SH01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016

    1 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    14 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    5 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 26. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1,001
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Sekretär
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147807910001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Sekretär
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Geschäftsführer
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CURRAN, Paul
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish110978610002
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MILLIGAN, Michael
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish153845120001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    Hat GLADEDALE (COMMERCIAL) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A bond and floating charge
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each residential obligor to any commercial secured party and any residential secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2009
    • 23. Juni 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Share pledge
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledged assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Shares pledge
    Erstellt am 30. Dez. 2008
    Geliefert am 08. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Entire right title and interest in and to the shares being 14,532,678 ordinary shares of £1 each held in gladedale capital limited, and all rights of a capital nature in respect of any of the shares, and all rights by way of dividend. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 17. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a land forming part of land at shoebury garrison, shoeburyness, essex, f/h property k/a the former officers' mess and adjoining land at shoebury garrison shoeburyness essex and f/h property k/a the former drill shed and adjoining land at shoebury garrison shoeburyness essex. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Defence
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 16. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a warwick castle park stratford road warwick t/no WK256708. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 16. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a building seventeen and adjoining land at the former royal ordinance depot weedon bec northamptonshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 16. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land forming part of land at shoebury garrison shoeburyness essex. F/h property k/a the former officers mess and adjoining land at shoebury garrison shoeburyness essex and the f/h property k/a the former drill shed and adjoining land at shoebury garrison shoeburyness essex. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 04. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H building seventeen and adjoining land at the former royal ordnance depot weedon bec northamptonshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 04. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H warwick castle park stratford road warwick t/n WK256708. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 04. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land forming part of land at shoebury garrison shoeburyness essex f/h former officesr's mess and adjoining land at shoebury garrison shoeburyness essex f/h former drill shed and adjoining land at shoebury garrison shoeburyness essex. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2007
    Geliefert am 21. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Scotland PLC (Formerly the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0