NEUTRINO CONCEPTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNEUTRINO CONCEPTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06084376
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NEUTRINO CONCEPTS LIMITED?

    • Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich NEUTRINO CONCEPTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NEUTRINO CONCEPTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ENSCO 573 LIMITED06. Feb. 200706. Feb. 2007

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEUTRINO CONCEPTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für NEUTRINO CONCEPTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    7 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. März 2016

    9 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von David William Preston als Geschäftsführer am 19. März 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Roman William Mcalindon als Geschäftsführer am 19. März 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Digby Marritt Jones als Geschäftsführer am 19. März 2015

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ zum 2Nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB am 07. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 18. März 2015

    LRESEX

    Ernennung von Mr Roman William Mcalindon als Direktor am 21. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Stirling als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 133,327
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Neutrino Concepts Limited 1 Devon Way Longbridge Technology Park Birmingham West Midlands B31 2TS England geändert

    1 SeitenAD02

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Woodward als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2013

    9 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 060843760015

    24 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 060843760016

    16 SeitenMR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 Devon Way Longbridge Technology Park Birmingham West Midlands B31 2TS England* am 29. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Bernard Hampson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David William Preston als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Roman Mcalindon als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Roman Mcalindon als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Antonia Mcalindon als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von NEUTRINO CONCEPTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PRESTON, David William
    Callow Hill Road
    Alvechurch
    B48 7LR Birmingham
    82
    England
    Sekretär
    Callow Hill Road
    Alvechurch
    B48 7LR Birmingham
    82
    England
    183346650001
    MCALINDON, Roman William
    Devon Way
    Longbridge Technology Park
    B31 2TS Birmingham
    1
    West Midlands
    England
    Sekretär
    Devon Way
    Longbridge Technology Park
    B31 2TS Birmingham
    1
    West Midlands
    England
    181264640001
    HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710002
    MCALINDON ASSOCIATES LIMITED
    34 Lickey Square
    Barnt Green
    B45 8HB Birmingham
    The Sharrow
    West Midlands
    United Kingdom
    Sekretär
    34 Lickey Square
    Barnt Green
    B45 8HB Birmingham
    The Sharrow
    West Midlands
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer0466809
    122370980002
    BAIRD, Nicholas Robert
    Deswood 19 Mearse Lane
    Barnt Green
    B45 8HQ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Deswood 19 Mearse Lane
    Barnt Green
    B45 8HQ Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish3461110001
    FOODY, Patrick John
    14 Poppleton Drive
    Tingley
    WF3 1UZ Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    14 Poppleton Drive
    Tingley
    WF3 1UZ Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish73242610001
    HAMPSON, Bernard William
    5 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JE Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    5 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JE Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish56704650002
    JONES, Digby Marritt, Lord
    Temple Grafton
    B49 6NT Temple Grafton
    Dove House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Temple Grafton
    B49 6NT Temple Grafton
    Dove House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish88447680004
    JONES, Digby Marritt, Lord
    Gannaway
    Norton Lindsey
    CV35 8JT Warwick
    Gannawag Gate
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Gannaway
    Norton Lindsey
    CV35 8JT Warwick
    Gannawag Gate
    Warwickshire
    EnglandBritish140118570001
    MCALINDON, Antonia Elizabeth
    Devon Way
    Longbridge Technology Park
    B31 2TS Birmingham
    1
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Devon Way
    Longbridge Technology Park
    B31 2TS Birmingham
    1
    West Midlands
    England
    EnglandBritish159646110001
    MCALINDON, Roman William
    Lickey Square
    Lickey
    B45 8HB Birmingham
    34
    England
    Geschäftsführer
    Lickey Square
    Lickey
    B45 8HB Birmingham
    34
    England
    United KingdomBritish87477000001
    MCALINDON, Roman William
    The Sharrow
    34 Lickey Square, Barnt Green
    B45 8HB Birmingham
    West Midlands
    Great Britain
    Geschäftsführer
    The Sharrow
    34 Lickey Square, Barnt Green
    B45 8HB Birmingham
    West Midlands
    Great Britain
    United KingdomBritish87477000001
    PRESTON, David William
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    2nd Floor
    EnglandBritish102053440001
    STIRLING, John Kenneth
    Mearse Lane
    Barnt Green
    B45 8DB Birmingham
    Beechfield 27
    England
    Geschäftsführer
    Mearse Lane
    Barnt Green
    B45 8DB Birmingham
    Beechfield 27
    England
    EnglandAustralian95884970001
    WOODWARD, Jonathan Lee
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    Geschäftsführer
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    EnglandBritish159763930002
    HBJGW INCORPORATIONS LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    68279000005

    Hat NEUTRINO CONCEPTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. Feb. 2014
    Geliefert am 28. Feb. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Unipart Group Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Feb. 2014
    Geliefert am 28. Feb. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Unipart Group Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Juli 2013
    Geliefert am 25. Juli 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Juli 2013
    Geliefert am 25. Juli 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Juli 2013
    Geliefert am 25. Juli 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Juli 2013
    Geliefert am 25. Juli 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Intellectual property rights charge
    Erstellt am 12. Okt. 2011
    Geliefert am 20. Okt. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future right title and interest in and to the secured property and all present and future rights of action under the secured property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon as Security Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2011
    Geliefert am 20. Okt. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon as Security Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Intellectual property rights charge
    Erstellt am 13. Juli 2010
    Geliefert am 17. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future right, title and interest in and to the company's intellectual and industrial property rights, the goodwill, all rights and interests in any exploitation agreement and all the right, title and interest throughout the world in any intellectual property rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 17. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 2010
    Geliefert am 17. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon as Security Trustee for the Beneficiairies
    Transaktionen
    • 17. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Intellectual property rights charge
    Erstellt am 31. März 2010
    Geliefert am 10. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all present and future right title and interest in and to the secured property. Secured property means the intellectual property rights and other related property and rights. All present and future rights of action, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 2010
    Geliefert am 10. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2009
    Geliefert am 10. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon as Security Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Intellectual property rights charge
    Erstellt am 30. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all right title and interest in and to the secured property and to any unregistered intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Intellectual property rights charge
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 23. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all right title and interest in and to the secured property and to any unregistered intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 23. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Roman Mcalindon (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)

    Hat NEUTRINO CONCEPTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. März 2015Beginn der Liquidation
    30. Dez. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Martin Stokes
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Gerald Clifford Smith
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praktiker
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0